LITTLE LONDON PUBS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LITTLE LONDON PUBS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00324650 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LITTLE LONDON PUBS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra LITTLE LONDON PUBS LIMITED?
| Dirección de la sede social | RESOLVE PARTNERS LIMITED 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LITTLE LONDON PUBS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CLEVELAND PLACE NOMINEE COMPANY (NO.2) LIMITED | 15 oct 1993 | 15 oct 1993 |
| GRAND METROPOLITAN NOMINEE COMPANY (NO.5) LIMITED | 28 may 1991 | 28 may 1991 |
| MANN CROSSMAN & PAULIN LIMITED | 25 feb 1937 | 25 feb 1937 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LITTLE LONDON PUBS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 22 ago 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LITTLE LONDON PUBS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 ene 2018 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL a 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU el 13 sept 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL el 09 feb 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 9 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de Lindsay Anne Keswick como secretario el 25 abr 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Susan Stewart como secretario el 25 abr 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT el 07 mar 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 22 ago 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daryl Antony Kelly como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Robert Langford como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lucy Jane Bell como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Kirk Dyson Davis como director el 21 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Henry Jones como secretario el 04 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 24 ago 2016 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Patrick James Gallagher como director el 23 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 23 ago 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 17 ago 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Claire Susan Stewart como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LITTLE LONDON PUBS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secretario | York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London 22 | 207523630001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| ADAMS, Susanne Margaret | Secretario | Azalea 167 High Street Northchurch HP4 3QT Berkhamsted Hertfordshire | British | 28738400002 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Secretario | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592200001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secretario | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445470001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Secretario | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181022020001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Director | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Director | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| HOMER, Neville Rex | Director | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Director | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Director | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Director | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton-On-Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Director | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MILLER, Louise | Director | 13 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 63895470001 | ||||||
| MYDDELTON, Roger Hugh | Director | 21 Lawford Road NW5 2LH London | British | 399500001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Director | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Director | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 |
¿Tiene LITTLE LONDON PUBS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 15 dic 2003 Entregado el 31 dic 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Twelfth supplemental trust deed | Creado el 30 sept 1985 Entregado el 07 oct 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £1,288,988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of ukp 349,595 5% redeemable debenture stock 2000 £243,200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & £696193 73/6% redeemable debenture stock 1988/93 & allother moneys intended to be secured by a trust deed dated 7/2/67 & deeds supplemented thereto. | |
Breve descripción First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 24 may 1983 Entregado el 25 may 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £50,000,000 121/8% redeemable debenture stock 2008 of watney mann & truman holdings PLC and for further securing all monies due or to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of a trust deedated 7TH february 1962 and deeds supplemental thereto. | |
Breve descripción The undertaking of the company and all its assets for the time being both present and future wheresoever situate (inlcuding any uncalled capital). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 28 jul 1970 Entregado el 12 ago 1970 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £53,127,463 including £45,627,463 secured by a trust deed dated 7.2.62 & deeds supplmental thereto. | |
Breve descripción First floating charge on undertaking and assets prsent and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 31 jul 1967 Entregado el 31 jul 1967 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to £45,627,463 inclusing £35,627,463 secured by trust deed dated 7.2.62 and deeds supplemental thereto. | |
Breve descripción First floating charge over undertaking and assets presnt and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Equitable charge | Creado el 08 may 1967 Entregado el 26 may 1967 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to 10,000,000 | |
Breve descripción Fixed floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 26 jul 1965 Entregado el 28 jul 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £7,500,000 debenture stock of watney mann LTD. | |
Breve descripción Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trut deed | Creado el 26 mar 1965 Entregado el 06 abr 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £1,347,28 debenture stock of wtney mann LTD. | |
Breve descripción Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 22 ene 1964 Entregado el 23 ene 1964 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to £8,000.000 | |
Breve descripción Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. (See doc. 82). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 08 feb 1962 Entregado el 08 feb 1962 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing £5,000,000 debenture stock of watney mann LTD. | |
Breve descripción Undertaking and all assets present and future including uncalled capital (see doc for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 07 feb 1962 Entregado el 07 feb 1962 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing £13,780,195 debenture stock of watney mann LTD. ( for further details see doc 77) | |
Breve descripción Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene LITTLE LONDON PUBS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0