IPT (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIPT (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00342480
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IPT (UK) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra IPT (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IPT (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    C.V. YARNS & FABRICS LIMITED01 feb 198901 feb 1989
    TOOTAL TEXTILES LIMITED28 ene 198228 ene 1982
    LUTON KNITTING CO.LIMITED14 jul 193814 jul 1938

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IPT (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IPT (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2020

    7 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2019

    8 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2018

    8 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2017

    12 páginasLIQ03

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 páginasLIQ MISC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Destitución del liquidador por orden judicial

    15 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2016

    9 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 20 oct 2016

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 25 Back Wallgate Macclesfield Cheshire SK11 6LQ a Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP el 27 ene 2016

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 31 dic 2015

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    2 páginasMR04

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2014 au 30 jun 2015

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 01 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 ago 2015

    Estado de capital el 03 ago 2015

    • Capital: GBP 39,055,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 ago 2014

    Estado de capital el 01 ago 2014

    • Capital: GBP 39,055,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de IPT (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHORE, Anthony James
    12 Benbrook Way
    Gawsworth
    SK11 9RT Macclesfield
    Cheshire
    Secretario
    12 Benbrook Way
    Gawsworth
    SK11 9RT Macclesfield
    Cheshire
    BritishGroup Finance Director78728190001
    RICHENS, Nigel
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    United KingdomUnited KingdomHead Office168843630001
    SHORE, Anthony James
    12 Benbrook Way
    Gawsworth
    SK11 9RT Macclesfield
    Cheshire
    Director
    12 Benbrook Way
    Gawsworth
    SK11 9RT Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director78728190001
    BOOTH, Brenda
    10 Trevor Road
    Flixton
    M41 5QH Manchester
    Secretario
    10 Trevor Road
    Flixton
    M41 5QH Manchester
    British16249170001
    SMITH, Michael Ernest
    Kiplings Ravenstock Lane
    Little Walden
    CB10 1XG Saffron Walden
    Essex
    Secretario
    Kiplings Ravenstock Lane
    Little Walden
    CB10 1XG Saffron Walden
    Essex
    BritishFinancial Director45878560002
    WADDELL, Douglas Malcolm
    High Gables
    218 Bramhall Lane South
    SK7 3AA Bramhall
    Cheshire
    Secretario
    High Gables
    218 Bramhall Lane South
    SK7 3AA Bramhall
    Cheshire
    BritishCompany Director53180040003
    WALTON, David
    51 Bradley Lane
    Eccleston
    PR7 5RJ Chorley
    Lancashire
    Secretario
    51 Bradley Lane
    Eccleston
    PR7 5RJ Chorley
    Lancashire
    British51338650001
    BUDDEN, Richard Gordon
    Belper House
    Dunsany
    County Meath
    Ireland
    Director
    Belper House
    Dunsany
    County Meath
    Ireland
    BritishTextile Executive106530610001
    COOPER, Eric Lilford
    25 Back Wallgate
    Macclesfield
    SK11 6LQ Cheshire
    Director
    25 Back Wallgate
    Macclesfield
    SK11 6LQ Cheshire
    EnglandBritishDirector34483250001
    COOPER, Eric Lilford
    Bradbourne Vale House
    Bradbourne Road
    TN13 3QB Sevenoaks
    Kent
    Director
    Bradbourne Vale House
    Bradbourne Road
    TN13 3QB Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishCompany Director34483250001
    DONALD, Gordon Hugh
    28 Fletcher Drive
    Bowdon
    WA14 3FZ Altrincham
    Cheshire
    Director
    28 Fletcher Drive
    Bowdon
    WA14 3FZ Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector70347280002
    DOW, Samuel
    Claremont
    Littleworth Common
    SL1 8PP Burnham
    Buckinghamshire
    Director
    Claremont
    Littleworth Common
    SL1 8PP Burnham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary452520001
    FARRAR, David
    Greengates Dark Lane
    S70 6RE Barnsley
    South Yorkshire
    Director
    Greengates Dark Lane
    S70 6RE Barnsley
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector55960630001
    FINNIGAN, John Allan, Dr
    High Ground Moor Lane
    Long Preston
    BD23 4QQ Skipton
    North Yorkshire
    Director
    High Ground Moor Lane
    Long Preston
    BD23 4QQ Skipton
    North Yorkshire
    BritishTextile Executive41461960001
    HARRISON, James Alfred
    Willow Paddock
    Hermitage Lane
    CW4 1HB Holmes Chapel
    Cheshire
    Director
    Willow Paddock
    Hermitage Lane
    CW4 1HB Holmes Chapel
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector12873420001
    HULL, Kevin Raymond
    19 Hannas Royd
    Dodworth
    S75 3SW Barnsley
    South Yorkshire
    Director
    19 Hannas Royd
    Dodworth
    S75 3SW Barnsley
    South Yorkshire
    BritishDirector38076240002
    I'ANSON, William Tony
    Oak House Garth Heights
    Wilmslow Park
    SK9 2BA Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Oak House Garth Heights
    Wilmslow Park
    SK9 2BA Wilmslow
    Cheshire
    BritishTextile Executive23055670001
    JEFFERIES, Basil
    Cromwells
    Watch House Green Felsted
    CM6 3EF Great Dunmow
    Essex
    Director
    Cromwells
    Watch House Green Felsted
    CM6 3EF Great Dunmow
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director122986140001
    LAIDLAW, William
    Old Boathouse Inn Agden Bridge
    WA13 0UH Lymm
    Cheshire
    Director
    Old Boathouse Inn Agden Bridge
    WA13 0UH Lymm
    Cheshire
    BritishTextile Executive54501930001
    SMITH, Michael Ernest
    Kiplings Ravenstock Lane
    Little Walden
    CB10 1XG Saffron Walden
    Essex
    Director
    Kiplings Ravenstock Lane
    Little Walden
    CB10 1XG Saffron Walden
    Essex
    BritishFinancial Director45878560002
    WADDELL, Douglas Malcolm
    High Gables
    218 Bramhall Lane South
    SK7 3AA Bramhall
    Cheshire
    Director
    High Gables
    218 Bramhall Lane South
    SK7 3AA Bramhall
    Cheshire
    BritishCompany Director53180040003
    WALLS, John Russell Fotheringham
    8 Burnfoot Avenue
    Fulham
    SW6 5EA London
    Director
    8 Burnfoot Avenue
    Fulham
    SW6 5EA London
    BritishFinancial Director43558350001
    WALTON, David
    51 Bradley Lane
    Eccleston
    PR7 5RJ Chorley
    Lancashire
    Director
    51 Bradley Lane
    Eccleston
    PR7 5RJ Chorley
    Lancashire
    BritishDirector51338650001

    ¿Tiene IPT (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 08 may 2001
    Entregado el 14 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 23 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 04 ago 1998
    Entregado el 19 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold properties k/a calder works thornhill road kirklees west yorkshire t/n WYK559037 and douglas mills bradley lane standish wigan t/n GM529889 and LA385140 and leasehold property k/a land lying to the south of bradley lane standish wigan t/n GM316841. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2001Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 23 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 04 ago 1998
    Entregado el 19 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a the lands and premises k/a 36 hillhead road ballyclare county antrim t/n folio 26099. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 23 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 mar 1995
    Entregado el 04 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined in the charge)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 10 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 28 mar 1995
    Entregado el 04 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined in the charge)
    Breve descripción
    Land and premises k/a 36 hillhead road ballyclare county antrim with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 10 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Omnibus letter of set-off
    Creado el 25 ene 1984
    Entregado el 03 feb 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or tootal group public limited comany to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Any sum/s for the time being standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 1984Registro de una carga
    Supplemental trust deed
    Creado el 27 ene 1969
    Entregado el 28 ene 1969
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Supplemental trust deed securing debenture stock on english calico LTD amounting to £11,700,000 inclusive of £5,000,00 secured by a trust deed dated 26 november 1965
    Breve descripción
    Floating charge on (see doc 68 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Schroder Executor & Trustee Company LTD
    Transacciones
    • 28 ene 1969Registro de una carga
    • 26 abr 1995Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 05 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage & further charge
    Creado el 03 feb 1960
    Entregado el 05 feb 1960
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £20000 and also the aggregate sum of £26000 secured by the charges dated respectively 15/9/52 & 12/5/58
    Breve descripción
    664 dunstable road, luton, beds and all the property comprised in the two charges dated 15/9/52 and 12/5/58.
    Personas con derecho
    • Eagle Star Insurance Co. LTD.
    Transacciones
    • 05 feb 1960Registro de una carga
    • 23 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Further charge
    Creado el 12 may 1958
    Entregado el 13 may 1958
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £14,000
    Breve descripción
    666/668, dunstable road, luton.
    Personas con derecho
    • Eagle Star Insurance Co. LTD.
    Transacciones
    • 13 may 1958Registro de una carga
    • 23 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene IPT (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 dic 2015Inicio de la liquidación
    01 ene 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Profesional
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0