IPT (UK) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | IPT (UK) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00342480 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IPT (UK) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra IPT (UK) LIMITED?
Dirección de la sede social | Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IPT (UK) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
C.V. YARNS & FABRICS LIMITED | 01 feb 1989 | 01 feb 1989 |
TOOTAL TEXTILES LIMITED | 28 ene 1982 | 28 ene 1982 |
LUTON KNITTING CO.LIMITED | 14 jul 1938 | 14 jul 1938 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IPT (UK) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IPT (UK) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2020 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2019 | 8 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2018 | 8 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2017 | 12 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Presentación de insolvencia Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl | 4 páginas | LIQ MISC | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 15 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2016 | 9 páginas | 4.68 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 20 oct 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 25 Back Wallgate Macclesfield Cheshire SK11 6LQ a Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP el 27 ene 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 9 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2014 au 30 jun 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 12 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de IPT (UK) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORE, Anthony James | Secretario | 12 Benbrook Way Gawsworth SK11 9RT Macclesfield Cheshire | British | Group Finance Director | 78728190001 | |||||
RICHENS, Nigel | Director | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | United Kingdom | United Kingdom | Head Office | 168843630001 | ||||
SHORE, Anthony James | Director | 12 Benbrook Way Gawsworth SK11 9RT Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 78728190001 | ||||
BOOTH, Brenda | Secretario | 10 Trevor Road Flixton M41 5QH Manchester | British | 16249170001 | ||||||
SMITH, Michael Ernest | Secretario | Kiplings Ravenstock Lane Little Walden CB10 1XG Saffron Walden Essex | British | Financial Director | 45878560002 | |||||
WADDELL, Douglas Malcolm | Secretario | High Gables 218 Bramhall Lane South SK7 3AA Bramhall Cheshire | British | Company Director | 53180040003 | |||||
WALTON, David | Secretario | 51 Bradley Lane Eccleston PR7 5RJ Chorley Lancashire | British | 51338650001 | ||||||
BUDDEN, Richard Gordon | Director | Belper House Dunsany County Meath Ireland | British | Textile Executive | 106530610001 | |||||
COOPER, Eric Lilford | Director | 25 Back Wallgate Macclesfield SK11 6LQ Cheshire | England | British | Director | 34483250001 | ||||
COOPER, Eric Lilford | Director | Bradbourne Vale House Bradbourne Road TN13 3QB Sevenoaks Kent | England | British | Company Director | 34483250001 | ||||
DONALD, Gordon Hugh | Director | 28 Fletcher Drive Bowdon WA14 3FZ Altrincham Cheshire | British | Director | 70347280002 | |||||
DOW, Samuel | Director | Claremont Littleworth Common SL1 8PP Burnham Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 452520001 | ||||
FARRAR, David | Director | Greengates Dark Lane S70 6RE Barnsley South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 55960630001 | ||||
FINNIGAN, John Allan, Dr | Director | High Ground Moor Lane Long Preston BD23 4QQ Skipton North Yorkshire | British | Textile Executive | 41461960001 | |||||
HARRISON, James Alfred | Director | Willow Paddock Hermitage Lane CW4 1HB Holmes Chapel Cheshire | United Kingdom | British | Director | 12873420001 | ||||
HULL, Kevin Raymond | Director | 19 Hannas Royd Dodworth S75 3SW Barnsley South Yorkshire | British | Director | 38076240002 | |||||
I'ANSON, William Tony | Director | Oak House Garth Heights Wilmslow Park SK9 2BA Wilmslow Cheshire | British | Textile Executive | 23055670001 | |||||
JEFFERIES, Basil | Director | Cromwells Watch House Green Felsted CM6 3EF Great Dunmow Essex | United Kingdom | British | Company Director | 122986140001 | ||||
LAIDLAW, William | Director | Old Boathouse Inn Agden Bridge WA13 0UH Lymm Cheshire | British | Textile Executive | 54501930001 | |||||
SMITH, Michael Ernest | Director | Kiplings Ravenstock Lane Little Walden CB10 1XG Saffron Walden Essex | British | Financial Director | 45878560002 | |||||
WADDELL, Douglas Malcolm | Director | High Gables 218 Bramhall Lane South SK7 3AA Bramhall Cheshire | British | Company Director | 53180040003 | |||||
WALLS, John Russell Fotheringham | Director | 8 Burnfoot Avenue Fulham SW6 5EA London | British | Financial Director | 43558350001 | |||||
WALTON, David | Director | 51 Bradley Lane Eccleston PR7 5RJ Chorley Lancashire | British | Director | 51338650001 |
¿Tiene IPT (UK) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creado el 08 may 2001 Entregado el 14 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 04 ago 1998 Entregado el 19 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Freehold properties k/a calder works thornhill road kirklees west yorkshire t/n WYK559037 and douglas mills bradley lane standish wigan t/n GM529889 and LA385140 and leasehold property k/a land lying to the south of bradley lane standish wigan t/n GM316841. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 04 ago 1998 Entregado el 19 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Property k/a the lands and premises k/a 36 hillhead road ballyclare county antrim t/n folio 26099. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 28 mar 1995 Entregado el 04 abr 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined in the charge) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 28 mar 1995 Entregado el 04 abr 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined in the charge) | |
Breve descripción Land and premises k/a 36 hillhead road ballyclare county antrim with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Omnibus letter of set-off | Creado el 25 ene 1984 Entregado el 03 feb 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or tootal group public limited comany to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Any sum/s for the time being standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental trust deed | Creado el 27 ene 1969 Entregado el 28 ene 1969 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Supplemental trust deed securing debenture stock on english calico LTD amounting to £11,700,000 inclusive of £5,000,00 secured by a trust deed dated 26 november 1965 | |
Breve descripción Floating charge on (see doc 68 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage & further charge | Creado el 03 feb 1960 Entregado el 05 feb 1960 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £20000 and also the aggregate sum of £26000 secured by the charges dated respectively 15/9/52 & 12/5/58 | |
Breve descripción 664 dunstable road, luton, beds and all the property comprised in the two charges dated 15/9/52 and 12/5/58. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Further charge | Creado el 12 may 1958 Entregado el 13 may 1958 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £14,000 | |
Breve descripción 666/668, dunstable road, luton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene IPT (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0