PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00344127 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
- Alquiler y arrendamiento de automóviles y vehículos de motor ligeros (77110) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| VANGUARD RENTAL (FRANCHISING) LIMITED | 17 dic 2003 | 17 dic 2003 |
| ANC RENTAL CORPORATION (FRANCHISING) LIMITED | 25 feb 2000 | 25 feb 2000 |
| REPUBLIC INDUSTRIES AUTOMOTIVE RENTAL GROUP (LICENSING) LIMITED | 29 ene 1998 | 29 ene 1998 |
| EURODOLLAR INTERNATIONAL LIMITED | 01 may 1990 | 01 may 1990 |
| EURODOLLAR RENT A CAR LIMITED | 16 ene 1989 | 16 ene 1989 |
| CALLANDERS (CAR RENTAL) LIMITED | 08 sept 1938 | 08 sept 1938 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 18 feb 2024 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 9 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 30 Finsbury Square London EC2A 1AG a C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB el 20 may 2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Lucy Brown Legal Counsel Europcar Group Uk Limited 1 Great Central Square Leicester LE1 4JS | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Great Central Square Leicester LE1 4JS England a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG el 13 feb 2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gary Neil Smith el 28 ene 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2023 au 30 dic 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 003441270009 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 003441270010 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Registro de la carga 003441270010, creada el 01 jul 2024 | 15 páginas | MR01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Ann-Christin Alef como director el 05 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ronald Santiago como director el 02 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 003441270005 | 4 p áginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 003441270007 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 003441270006 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 003441270008 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marie-Helene Korvin como director el 23 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEF, Ann-Christin | Director | 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp | Germany | German | 321604850001 | |||||
| CARSON, Christopher Edward | Director | Great Central Square LE1 4JS Leicester 1 England | England | British | 277864820002 | |||||
| SMITH, Gary Neil | Director | 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp | England | British | 157695700001 | |||||
| COLTON, Jane Margaret | Secretario | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire | British | 35540850004 | ||||||
| MILES, Anthony Neil | Secretario | 10 Trow Lock Avenue TW11 9QT Teddington Middlesex | British | 24852500002 | ||||||
| ALDOUS, Frederick Herbert | Director | 16 The Chyne South Park SL9 8HZ Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 396990003 | |||||
| ALEXANDER, Anthony | Director | Pippins Crutches Lane Jordans HP9 2TG Beaconsfield Buckinghamshire | British | 6838380001 | ||||||
| COLTON, Jane Margaret | Director | Welford Road LE2 7AR Leicester James House, 55 Leicestershire | United Kingdom | British | 172480320002 | |||||
| CORBETT, Geoffrey Edward Hall | Director | 6 Christie Close KT23 3QP Bookham Surrey | British | 98359240001 | ||||||
| CUSTAGE, Dennis Michael | Director | Diss Park 32 Marsham Lane SL9 8HD Gerrards Cross Buckinghamshire | American | 65246680002 | ||||||
| ESTEVE JAQUOTOT, Federico | Director | Bombita 4 28043 Madrid Spain | Spanish | 44858840001 | ||||||
| KORVIN, Marie-Helene | Director | Great Central Square LE1 4JS Leicester 1 England | France | French | 289469230001 | |||||
| LEIGH, John Simon | Director | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 77954120001 | |||||
| LEIGH, John Simon | Director | Priory House Priory Road SL5 9RQ Sunningdale Berkshire | United Kingdom | British | 77954120001 | |||||
| MAITRE, Gerard | Director | 7 Rue De Mademoiselle 78000 Versailles France | French | 44858960001 | ||||||
| MILES, Anthony Neil | Director | 10 Trow Lock Avenue TW11 9QT Teddington Middlesex | British | 24852500002 | ||||||
| MORTIERE, Thierry De La | Director | 4 Bis Rue P.V. Couturier 92300 Le Vallois Perret France | French | 44895280001 | ||||||
| MOSLEY, Ian Christopher | Director | Middlewood House Jordans Way, Jordans HP9 2SP Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 81842870001 | |||||
| MYCROFT, John Keith | Director | Farm View Barton Stacey SO21 3RH Winchester Hampshire | British | 70413820001 | ||||||
| OWENS, Stuart Gordon | Director | Reeds Crescent WD24 4PH Watford Europcar, Oak House England | United Kingdom | British | 175108900001 | |||||
| PACKER, Malcolm Lloyd | Director | 8 Wexham Place Framewood Road Wexham SL2 4QX Slough | British | 43831810001 | ||||||
| PELIGRY, Luc Etienne | Director | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire | France | French | 249478450001 | |||||
| PENFOLD, Ian Jeremy | Director | 3 The Spinney Thurnby LE7 9QS Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 126885950001 | |||||
| SANTIAGO, Ronald | Director | Great Central Square LE1 4JS Leicester 1 England | United Kingdom | American | 277864540001 | |||||
| SUMMERVILLE, Neil | Director | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 129232420001 | |||||
| WARDLE, Ian | Director | Lynbrook Cherry Garden Lane SL6 3QD Maidenhead Berkshire | British | 53662440001 | ||||||
| WESTOBY, Stephen Charles | Director | 3 Ashwood Park Ashwood Road GU22 7HY Woking Surrey | British | 35848940002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premierfirst Vehicle Rental Holdings Limited | 06 abr 2016 | Great Central Square LE1 4JS Leicester 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0