DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED

DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED
    Estado de la empresaEn administración
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00344823
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DEBENHAMS PROPERTIES LIMITED20 ago 199720 ago 1997
    FREEBODY PROPERTIES LIMITED20 feb 198420 feb 1984
    DEBENHAMS (PROPERTIES) LIMITED30 sept 193830 sept 1938

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 ago 2019
    Próximas cuentas vencen el31 ago 2020
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 sept 2018

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta05 jul 2020
    Próxima declaración de confirmación vence16 ago 2020
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta05 jul 2019
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Informe de progreso del administrador

    38 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    35 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    35 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    36 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    47 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    37 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    44 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    45 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    45 páginasAM10

    Domicilio social registrado cambiado de Bedford House Park Street Taunton Somerset TA1 4DB England a 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU el 17 ago 2021

    2 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador

    41 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name09 feb 2021

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 26 ene 2021

    RES15

    Domicilio social registrado cambiado de 334 - 348 Oxford Street London W1C 1JG England a Bedford House Park Street Taunton Somerset TA1 4DB el 08 feb 2021

    1 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador

    48 páginasAM10

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA

    12 páginasAM02

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Declaración de la propuesta del administrador

    101 páginasAM03

    Nombramiento de un administrador

    3 páginasAM01

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    11 páginasCVA4

    Cese del nombramiento de Sally Hopwood como secretario el 09 abr 2020

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DARWALL, Alice Ann
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Secretario
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    257967880001
    EARDLEY, Paul Rex
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Secretario
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    254483480001
    EARDLEY, Paul Rex
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Secretario
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    British74477320006
    HARRISON, Rosalynde
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Secretario
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    251921990001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Secretario
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    HOPWOOD, Sally
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Secretario
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    268365760001
    JOHNSON, Guy Antony
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Secretario
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    British29729020004
    SMITH, Philip Clayton
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretario
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British613980001
    DEBENHAMS PLC
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10 Brock Street
    Secretario corporativo
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10 Brock Street
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5448421
    313829910001
    ADAMS, David
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Director
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    EnglandBritish239339020001
    BATES, David John
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish613990001
    BROWN, David Nigel
    8 Flora Grove
    AL1 5ET St Albans
    Hertfordshire
    Director
    8 Flora Grove
    AL1 5ET St Albans
    Hertfordshire
    British40354400002
    BUCHER, Sergio Rodriguez
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomSpanish216512370001
    CLIFFORD-KING, Martin
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British77456620001
    COATES, David Peter
    Stamford Lodge
    37 Priestlands Park Road
    DA15 7HJ Sidcup
    Kent
    Director
    Stamford Lodge
    37 Priestlands Park Road
    DA15 7HJ Sidcup
    Kent
    British56148130001
    DUDDY, Terence
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    EnglandBritish256736950001
    HARLOW, Suzanne
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish183585370001
    HAZELL, Mike
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Director
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    United KingdomBritish263031350001
    HERRICK, Simon Edward
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish70414940003
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Director
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Director
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    JOHNSON, Guy Antony
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Director
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    British29729020004
    KILBEY, Graham John
    20 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QJ Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    20 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QJ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish150198820001
    LOVERING, John David
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Director
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    United KingdomBritish73573160004
    MURPHY, James William
    Pheasants Copse
    Rotherfield Greys
    RG9 4QJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Pheasants Copse
    Rotherfield Greys
    RG9 4QJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    NoneBritish4145300002
    OSBORNE, Rachel Claire Elizabeth
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United KingdomBritish250468300001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Director
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    British54689210005
    SHARP, Michael John Todkill
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish153448810002
    SHEPHERD, Jessica Louise
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United KingdomBritish252987620001
    SKINNER, Patricia Valda
    11 Manor Drive
    NW7 3ND London
    Director
    11 Manor Drive
    NW7 3ND London
    United KingdomBritish28667500001
    SMITH, David
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish245720490001
    SMITH, Matthew George
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish194410880002
    SMITH, Philip Clayton
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Director
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British613980001
    TEMPLEMAN, Robert William
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Director
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    UkBritish88293210002
    TIMMINS, Gail
    4 Oldean Close
    Tilehurst
    RG31 5QA Reading
    Berkshire
    Director
    4 Oldean Close
    Tilehurst
    RG31 5QA Reading
    Berkshire
    EnglandBritish56148250002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Celine Group Holdings Limited
    Oxford Street
    W1C 1JG London
    334-348
    England
    06 abr 2016
    Oxford Street
    W1C 1JG London
    334-348
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroDebenhams Properties Limited
    Número de registro3430071
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 ene 2020
    Entregado el 28 ene 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    Argentine trade mark registration number 2421249 and the additional ip listed in part 6 intellectual property rights) of schedule 2 of the attached charging document.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 28 ene 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 09 oct 2019
    Entregado el 18 oct 2019
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 18 oct 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 09 abr 2019
    Entregado el 11 abr 2019
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 11 abr 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 29 mar 2019
    Entregado el 01 abr 2019
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 01 abr 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 11 feb 2019
    Entregado el 19 feb 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 19 feb 2019Registro de una carga (MR01)
    • 04 abr 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creado el 27 jun 2005
    Entregado el 06 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee, as owed or incurred by each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse,London Branch
    Transacciones
    • 06 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 abr 2004
    Entregado el 06 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the beneficial owner (roadstream limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H land and buildings k/a store a, the st david's centre, cardiff, south glamorgan t/n:WA546525. L/h land and buildings k/a 275-287 (odd) station road, harrow t/n:NGL274785.for details of further properties charged please refer to form 395.first fixed charge: all of its rights and benefit under any agreement relating to the acquisition of the mortgaged properties, all plant and machinery, all of its benefits, claims and returns of premiums in respect of the insurances, all of its right, title and interest (if any) under the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Landesbank (Acting Through Its London Branch as Security Agent for Itself and Theother Beneficiaries)
    Transacciones
    • 06 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession and charge
    Creado el 19 dic 2003
    Entregado el 22 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security agent for the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse First Boston, London Branch as Security Agent
    Transacciones
    • 22 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of admission pursuant to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 01/04/86
    Creado el 23 jul 1986
    Entregado el 05 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever supplemental to a letter of set-off dated 1/4/86
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 1986Registro de una carga
    • 13 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Omnibus guarantee & setoff agreement
    Creado el 01 abr 1986
    Entregado el 11 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 1986Registro de una carga
    • 13 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene DEPARTMENT STORES REALISATIONS (PROPERTIES) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    09 may 2019Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    06 abr 2020Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    James Robert Tucker
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Edward George Boyle
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    2
    FechaTipo
    09 abr 2020Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Geoffrey Paul Rowley
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Profesional
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Profesional
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0