BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00349201 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED?
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Suite S10 One Devon Way Longbridge B31 2TS Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ST. MODWEN PROPERTIES LIMITED | 12 ago 2021 | 12 ago 2021 |
| ST. MODWEN PROPERTIES PLC | 21 abr 1986 | 21 abr 1986 |
| REDMAN HEENAN INTERNATIONAL PLC | 03 feb 1939 | 03 feb 1939 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 24 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 07 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Daniel Stephen Park el 13 ene 2026 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 45 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 003492010027 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||||||
Modification des détails de Mr Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 jun 2025 | 2 páginas | PSC04 | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Lisa Ann Katherine Minns como secretario el 01 abr 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed st. Modwen properties LIMITED\certificate issued on 20/03/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Stephen Park como director el 26 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nombramiento de Nicholas Karl Vuckovic como director el 26 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sarwjit Sambhi como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Two Devon Way Longbridge Birmingham B31 2TS United Kingdom a Suite S10 One Devon Way Longbridge Birmingham B31 2TS el 11 feb 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 57 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Anthony Lewis Olsen como director el 01 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 may 2024
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Subdivisión de acciones el 28 may 2024 | 3 páginas | SH02 | ||||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 30 may 2024
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Estado de capital el 31 may 2024
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 4 páginas | SH20 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 5 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Estado de capital el 29 may 2024
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 4 páginas | SH20 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 4 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAUSE, Peter Christopher | Director | One Devon Way Longbridge B31 2TS Birmingham Suite S10 United Kingdom | United Kingdom | American | 265297560001 | |||||
| PARK, Daniel Stephen | Director | One Devon Way Longbridge B31 2TS Birmingham Suite S10 United Kingdom | United Kingdom | British | 283039940002 | |||||
| PORTER, Nicholas | Director | One Devon Way Longbridge B31 2TS Birmingham Suite S10 United Kingdom | United Kingdom | British | 286015770002 | |||||
| SHAH, Adam Khisro Mir | Director | One Devon Way Longbridge B31 2TS Birmingham Suite S10 United Kingdom | United Kingdom | British | 216326190001 | |||||
| VUCKOVIC, Nicholas Karl | Director | One Devon Way Longbridge B31 2TS Birmingham Suite S10 United Kingdom | United Kingdom | British | 320684580001 | |||||
| DOONA, Paul Ernest | Secretario | 10 Hartopp Road Four Oaks Estate B74 2RQ Sutton Coldfield West Midlands | British | 9262110003 | ||||||
| DUNN, Michael Edward | Secretario | Sir Stanley Clarke House 7 Ridgeway B32 1AF Quinton Business Park Birmingham | 164470560001 | |||||||
| EAMES, Andrew David | Secretario | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | 240113530001 | |||||||
| GREEN, Antony Charles | Secretario | 192b Thornhill Road Streetly B74 2EP Sutton Coldfield West Midlands | British | 9519560002 | ||||||
| HAYWOOD, Timothy Paul | Secretario | Acton DY13 9TF Stourport On Severn The Yeoman House Worcestershire | British | 135906340001 | ||||||
| HAYWOOD, Timothy Paul | Secretario | The Yeoman House Acton DY13 9TF Stourport On Severn Worcestershire | British | 62962370002 | ||||||
| HAYWOOD, Timothy Paul | Secretario | The Yeoman House Acton DY13 9TF Stourport On Severn Worcestershire | British | 62962370002 | ||||||
| HUDSON, Robert Jan | Secretario | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | 239762930001 | |||||||
| HUMPHREYS, John Christopher | Secretario | 46 Cheswick Way Cheswick Green B90 4HE Solihull West Midlands | British | 116764360001 | ||||||
| MESSENT, Jon | Secretario | Singlets Lane Flamstead AL3 8EP St Albans 6 Hertfordshire | British | 157179420001 | ||||||
| MINNS, Lisa Ann Katherine | Secretario | One Devon Way Longbridge B31 2TS Birmingham Suite S10 United Kingdom | 281256360001 | |||||||
| OLIVER, William Alder | Secretario | Westfields Court CV35 9DB Moreton Morrell Warwickshire | British | 35518250002 | ||||||
| STOKES, Reeta | Secretario | 7 Ridgeway Quinton Business Park B32 1AF Birmingham Sir Stanley Clarke House | British | 147312510001 | ||||||
| STOTE, Tanya | Secretario | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | 167250570001 | |||||||
| ST. MODWEN CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 7 Ridgeway Quinton Business Park B32 1AF Birmingham Sir Stanley Clarke House | 136850980001 | |||||||
| ALLAN, Mark Christopher | Director | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | England | British | 74371010007 | |||||
| BULL, Ian Alan | Director | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | England | British | 210299090001 | |||||
| BURKE, Stephen James | Director | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | United Kingdom | British | 220387120001 | |||||
| CHALDECOTT, Kay Elizabeth | Director | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | England | British | 68694110003 | |||||
| CLARKE, Simon William | Director | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | England | British | 153092120001 | |||||
| CLARKE, Stanley William, Sir | Director | The Knoll Main Street DE13 8AB Barton Under Needwood Staffordshire | British | 9443230001 | ||||||
| DOONA, Paul Ernest | Director | 10 Hartopp Road Four Oaks Estate B74 2RQ Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 9262110003 | |||||
| DUNN, Michael Edward | Director | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | United Kingdom | British | 156438870001 | |||||
| FRANCIS, Mary Elizabeth | Director | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire | Uk | British | 72906570001 | |||||
| FROGGATT, Richard Lindsay | Director | Wharfe House 11 Riverside Walk LS29 9HP Ilkley | England | British | 23325510004 | |||||
| GARMAN, David Noel Christopher | Director | Sir Stanley Clarke House 7 Ridgeway B32 1AF Quinton Business Park Birmingham | England | British | 177736170001 | |||||
| GLOSSOP, Charles Compton Anthony | Director | Sir Stanley Clarke House 7 Ridgeway B32 1AF Quinton Business Park Birmingham | United Kingdom | British | 9265210001 | |||||
| GRAY, Danuta | Director | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | England | British | 191445090003 | |||||
| GREENWOOD, Jenefer Dawn | Director | 17 High Street Longbridge B31 2UQ Birmingham Park Point United Kingdom | England | British | 193553900001 | |||||
| HAYWOOD, Timothy Paul | Director | Sir Stanley Clarke House 7 Ridgeway B32 1AF Quinton Business Park Birmingham | United Kingdom | British | 62962370002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BRIGHTON STM PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton Bidco Ltd | 06 ago 2021 | Esplanade JE4 9WG St Helier 44 Jersey | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Stephen Allen Schwarzman | 06 ago 2021 | One Devon Way Longbridge B31 2TS Birmingham Suite S10 United Kingdom | No | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0