WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE)
Visión general
| Nombre de la empresa | WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE) |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 00350808 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE)?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE)?
| Dirección de la sede social | Unit 14 The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Cambs England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE)?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE)?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 23 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 06 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 23 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE)?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 23 oct 2025 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 1 the Chase Leverington Road Wisbech Cambs PE13 1RX England a Wisbech Society the Old Chapel North End Wisbech Cambs PE13 1PE | 1 páginas | AD02 | ||
Cambio de datos del director Mr Daljit Roy el 24 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Peter Anton Freeman el 24 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Susanah Louise Farmer el 24 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Paul Edward Eden el 24 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr David Edwin Crouch el 24 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Raymond Alfred Johnson el 24 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Richard Symond Gyles Barnwell el 24 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 15 páginas | AA | ||
Nombramiento de Vivien Mary Macrae como director el 27 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mr Robert Allen Hodgson el 27 feb 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 9/10 the Crescent Wisbech Cambs PE13 1EH England a Unit 14 the Boathouse Business Centre 1 Harbour Square Wisbech Cambs PE13 3BH el 11 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 oct 2024 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Symond Gyles Barnwell como secretario el 17 oct 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Eric Townshend Somerville como director el 17 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Roger Powell como director el 17 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Kathleen Mary Powell como director el 17 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 15 páginas | AA | ||
Cambio de datos del secretario Richard Symond Gyles Barnwell el 02 oct 2024 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Richard Symond Gyles Barnwell el 02 oct 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Daljit Roy como director el 23 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Aldo Ierubino como director el 09 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Richard John Sutcliffe Wilcock como director el 15 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE)?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNWELL, Richard Symond Gyles | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs United Kingdom | United Kingdom | British | 25317630007 | |||||
| CROUCH, David Edwin | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs United Kingdom | United Kingdom | British | 16799480002 | |||||
| EDEN, Paul Edward | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs United Kingdom | United Kingdom | British | 176368920002 | |||||
| FARMER, Susanah Louise | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs England | United Kingdom | British | 263218870001 | |||||
| FREEMAN, Peter Anton | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs England | England | British | 239539150001 | |||||
| HODGSON, Lorena Jane | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs England | United Kingdom | British | 36432730006 | |||||
| HODGSON, Robert Allen | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs England | United Kingdom | British | 36432740005 | |||||
| JOHNSON, Raymond Alfred | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs United Kingdom | England | British | 99459160001 | |||||
| MACRAE, Vivien Mary | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs England | England | British | 123156660002 | |||||
| RIX, Keith John Barkclay | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs England | England | British | 288373980001 | |||||
| ROY, Daljit | Director | The Boathouse Business Centre 1 Harbour Square PE13 3BH Wisbech Unit 14 Cambs England | England | British | 147200550002 | |||||
| BARNWELL, Richard Symond Gyles | Secretario | Great Cransley NN14 1PX Kettering Cransley Lodge Northamptonshire United Kingdom | British | 25317630002 | ||||||
| MITCHELL, Gay Stella | Secretario | 33 Pickards Way PE13 1SD Wisbech Cambridgeshire | English | 30929650001 | ||||||
| THORNETT, Joyce | Secretario | Stewards Corner Leverington Common PE13 5BP Wisbech Cambs | British | 25317600001 | ||||||
| ALLEN, Michael John | Director | 3 Mansell Road PE13 2SP Wisbech Cambridgeshire | England | British | 25317610001 | |||||
| BALL, David William | Director | Buckley House Bucksholt Road Walsoken PE14 7AR Wisbech Cambridgeshire | British | 25317620001 | ||||||
| CARLISLE, Elizabeth Ann | Director | 22 North Brink PE13 1JR Wisbech Cambridgeshire | England | British | 25317640001 | |||||
| CARLISLE, Elizabeth Ann | Director | 22 North Brink PE13 1JR Wisbech Cambridgeshire | England | British | 25317640001 | |||||
| CAVE, Margaret Lilian Mary | Director | Golden Court London Road TW7 4EG Isleworth 14 Surrey United Kingdom | England | British | 61239970002 | |||||
| CAVE, Peter Harford, Dr | Director | 12 Clarkson Avenue PE13 2EG Wisbech Cambridgeshire | British | 25317750001 | ||||||
| CHESTERS, John Denzil Robertson | Director | Little Orchard 55 Elmside Emneth PE14 8BQ Wisbech Cambridgeshire | British | 25317760002 | ||||||
| CLAYTON, Peter John | Director | Oldfield House 132 Fridaybridge Road PE14 0AT Wisbech Cambs | England | British | 33443850001 | |||||
| COOK, James Alan William | Director | Emneth PE14 8DE Wisbech 7 Hungate Road Cambs United Kingdom | United Kingdom | British | 209205320001 | |||||
| CROFTS, Peter Archibald | Director | Briar Patch Elm High Road PE13 2SJ Wisbech Cambs | British | 25317650001 | ||||||
| DAVIS, Norman Edward | Director | Salts Road West Walton PE14 7EJ Wisbech 21 Cambridgeshire | England | British | 146755940001 | |||||
| DOUGHTY, Robert Leslie | Director | 79 Sutton Road Leverington PE13 5DR Wisbech Cambridgeshire | British | 25317660001 | ||||||
| ELGOOD, Anne Mary | Director | North Brink PE13 1LN Wisbech 71 Cambridgeshire | United Kingdom | British | 12635110002 | |||||
| EVERALL, Jennifer Anne | Director | 2 Tower Gardens North Brink PE13 1LA Wisbech Cambridgeshire | British | 52131600002 | ||||||
| GIBBS, Bernard Frederick | Director | 75 Harecroft Road PE13 1RL Wisbech Cambridgeshire | England | British | 10758820001 | |||||
| GIBSON, Martin John | Director | Batcombe BA4 6HD Shepton Mallet Boxbush Farm Somerset England | England | British | 55972540006 | |||||
| GREER, Alexander William, Dr | Director | Newton Hall Hall Road, Walpole Highway PE14 7QE Wisbech Cambridgeshire | British | 78120360001 | ||||||
| GROUNDS, Frederick Ambrose Nicholas | Director | 41 York Road PE13 2EB Wisbech Cambridgeshire | England | British | 52131720001 | |||||
| HOLMES, Bridget | Director | 34 A Princes Road PE13 2PG Wisbech Cambridgeshire | England | British | 90155140001 | |||||
| HUTCHINSON, Michael Leslie | Director | The Old Vicarage 25 Ryston Road PE38 0DP Downham Market Norfolk | England | British | 115050250001 | |||||
| IERUBINO, Aldo | Director | Museum Square PE13 1ES Wisbech 1 England | England | Italian | 239540090003 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para WISBECH SOCIETY & PRESERVATION TRUST LIMITED(THE)?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 23 oct 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0