00366966 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresa00366966 LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00366966
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de 00366966 LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra 00366966 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 00366966 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRW CLIFFORD LIMITED05 may 194105 may 1941

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de 00366966 LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2006
    Próximas cuentas vencen el31 oct 2007
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2005

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para 00366966 LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta28 may 2017
    Próxima declaración de confirmación vence11 jun 2017
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para 00366966 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para 00366966 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Garry Elliot Barnes como director el 06 feb 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Geoffrey Peter Martin como director el 20 feb 2023

    1 páginasTM01

    Restauración por orden judicial

    5 páginasAC92

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed north bridge\certificate issued on 23/11/15
    páginasCERTNM

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 dic 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 jun 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 dic 2010

    5 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de * Mazars Llp Lancaster House 67 Newhall Street Birmingham B3 1NG* el 07 oct 2010

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 jun 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 dic 2009

    5 páginas4.68

    Cambio de datos del director Garry Elliot Barnes el 08 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Geoffrey Peter Martin el 08 oct 2009

    2 páginasCH01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 jun 2009

    6 páginas4.68

    legacy

    1 páginas288b

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 dic 2008

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 05 dic 2008

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    5 páginas4.68

    legacy

    1 páginas288c

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    legacy

    1 páginas287

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de 00366966 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARON, Philip Arthur
    154 Oak Farm Road
    Kings Norton
    B30 1EU Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    154 Oak Farm Road
    Kings Norton
    B30 1EU Birmingham
    West Midlands
    British11800590001
    CORKER, Eric
    3 Wentworth Road
    B74 2SG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    3 Wentworth Road
    B74 2SG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British271170001
    CROOKS, Simon Peter
    18 Glaston Drive
    Hillfield
    B91 3YE Solihull
    West Midlands
    Secretario
    18 Glaston Drive
    Hillfield
    B91 3YE Solihull
    West Midlands
    British118078950001
    HADDLETON, Dennis Roy
    37 Willesley Gardens
    LE65 2QE Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Secretario
    37 Willesley Gardens
    LE65 2QE Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British16277980001
    HAZENBERG, Pieter Arthur
    Netherfield
    21 Lansdowne Avenue Codsall
    WV8 2EN Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Netherfield
    21 Lansdowne Avenue Codsall
    WV8 2EN Wolverhampton
    West Midlands
    British36559270001
    KEEN, Richard
    The Highlands Hollow Tree Lane
    Vigo, Blackwell
    B60 1PR Bromsgrove
    Worcestershire
    Secretario
    The Highlands Hollow Tree Lane
    Vigo, Blackwell
    B60 1PR Bromsgrove
    Worcestershire
    British7825570001
    MAIONE, Tony
    25 Castle Road
    CV8 1NG Kenilworth
    Warwickshire
    Secretario
    25 Castle Road
    CV8 1NG Kenilworth
    Warwickshire
    British78413450002
    MCDONALD, Ross Edward
    115 Walsall Road
    Four Oaks
    B74 4NP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    115 Walsall Road
    Four Oaks
    B74 4NP Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Secretary44092870003
    BARNES, Garry Elliot, Mr.
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Director
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    EnglandBritishAccountant261469100001
    CORKER, Eric
    3 Wentworth Road
    B74 2SG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    3 Wentworth Road
    B74 2SG Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Secretary271170001
    GETHINS, Clive John
    7 Ashley Court Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8XB Birmingham
    West Midlands
    Director
    7 Ashley Court Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8XB Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director40805200001
    HAZENBERG, Pieter Arthur
    Netherfield
    21 Lansdowne Avenue Codsall
    WV8 2EN Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    Netherfield
    21 Lansdowne Avenue Codsall
    WV8 2EN Wolverhampton
    West Midlands
    UkBritishDirector36559270001
    HUGHES, Frederick Michael
    Little Banks 43 Middleton Road
    B74 3ES Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    Little Banks 43 Middleton Road
    B74 3ES Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishChief Executive16278000001
    LENHAM, David John
    15 Waterdale
    Compton
    WV3 9DY Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    15 Waterdale
    Compton
    WV3 9DY Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director67111300001
    MARTIN, Geoffrey Peter
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Director
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    United KingdomBritishDirector70138900002
    MCDONALD, Ross Edward
    21b Four Oaks Road
    Four Oaks
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    21b Four Oaks Road
    Four Oaks
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishChartered Secretary44092870005
    MEAD, Horace Sidney
    Heath Farm House
    Lighthorne
    CV35 0AU Coventry
    Warwickshire
    Director
    Heath Farm House
    Lighthorne
    CV35 0AU Coventry
    Warwickshire
    BritishManaging Director32780100001
    SHEPHERD, Peter David
    10 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Director
    10 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant47155840001
    TAHANY, Martin Peter
    78 New Walk
    LE1 6TF Leicester
    Leicestershire
    Director
    78 New Walk
    LE1 6TF Leicester
    Leicestershire
    BritishChairman4516900001
    TANSLEY, Peter George
    Willowbrook
    Millfield
    DE72 2HD Shardlow
    Derbyshire
    Director
    Willowbrook
    Millfield
    DE72 2HD Shardlow
    Derbyshire
    BritishManaging Director64212440001

    ¿Tiene 00366966 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture
    Creado el 26 mar 1992
    Entregado el 10 abr 1992
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 1992Registro de un cargo (395)
    Collateral debentture
    Creado el 26 mar 1992
    Entregado el 31 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from linread public limited company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 14 feb 1985
    Entregado el 19 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from tradeshaw limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of an agreement dated 14/2/85.
    Breve descripción
    (See M97 & attached schedules). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 19 feb 1985Registro de una carga
    Collateral mortgage
    Creado el 23 nov 1982
    Entregado el 01 dic 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from tradeshaw limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed charge over f/h property situate at or near abbey lane and abbey park road, leicester comprised in title no:- lt 15535.
    Personas con derecho
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 01 dic 1982Registro de una carga
    Collateral mortgage
    Creado el 11 may 1982
    Entregado el 18 may 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from tradeshaw limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed charge on the equipment of the company see attached list. Together with all additions accessories replacements & renewals of component parts and the benefit of any obligation & warranties and benefit of all maintenance agreements.
    Personas con derecho
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 18 may 1982Registro de una carga
    Collateral mortgage
    Creado el 11 may 1982
    Entregado el 18 may 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from tradeshaw limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    F/H property at or rear abbey lane & abbey park road leicester title nos lt 2288 lt 8904 lt 12809 and lt 66811.
    Personas con derecho
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 18 may 1982Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 19 mar 1982
    Entregado el 31 mar 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill & all fixtures inc. Trade fixtures fixed plant & machinery & heritable property in scotland. (See doc M93).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1982Registro de una carga

    ¿Tiene 00366966 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 jun 2012Fecha de disolución
    06 dic 2006Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Alistair Steven Wood
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Profesional
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0