UNION PUMP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUNION PUMP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00366985
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de UNION PUMP LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra UNION PUMP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    . Green Road
    Penistone
    S36 6BJ Sheffield
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UNION PUMP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DAVID BROWN UNION PUMPS LIMITED03 abr 199803 abr 1998
    DAVID BROWN PUMPS LIMITED28 mar 198928 mar 1989
    DAVID BROWN PUMPS & FABRICATIONS LIMITED22 jun 198822 jun 1988
    DAVID BROWN ESTATES LIMITED07 may 194107 may 1941

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de UNION PUMP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para UNION PUMP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 may 2016

    Estado de capital el 16 may 2016

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Cambio de datos del director Jeremy Wade Smeltser el 26 sept 2015

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Balkar Sohal como director el 26 sept 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Paul Andrew Cahill como director el 26 sept 2015

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 may 2015

    Estado de capital el 27 may 2015

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Cese del nombramiento de Kevin Lucius Lilly como director el 03 abr 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Stephen Tsoris como director el 03 abr 2015

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Balkar Sohal el 22 sept 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mark Edward Shanahan el 22 sept 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 jun 2014

    Estado de capital el 11 jun 2014

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Cese del nombramiento de Christopher Brown como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Thomas Brown como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Kevin Lucius Lilly el 01 ene 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Jeremy Wade Smeltser el 01 ene 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Balkar Sohal el 12 may 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mark Edward Shanahan el 15 may 2013

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Allan Dowie como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de UNION PUMP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CAHILL, Paul Andrew
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant202085370001
    SHANAHAN, Mark Edward
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    Director
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector165707440001
    SMELTSER, Jeremy Wade
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    Director
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanCfo, Spx Flow, Inc.163313000001
    TSORIS, Stephen
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    Director
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanDirector197069810001
    ASHMAN, Linda Margaret
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretario
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    British86730910001
    BROWN, Thomas James
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    Secretario
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    BritishCompany Secretary60773560001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    British29591090001
    TULLEY, Karen Ann
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor59112980002
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    Director
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director1876370002
    ANDREWS, Alan
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAftermarket Director52101720001
    BAILEY, Derek
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishEngineering And Technical Serv29591110001
    BLACKWELL, Malcolm
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    Director
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    United KingdomBritishManaging Director40752710001
    BRADWELL, Garth Jeffrey
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    BritishFinance Director66587570001
    BROWN, Christopher John
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    Director
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Managing Director1698880001
    COOK, Christopher David
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    Director
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director1698890001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    Director
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    BritishFinance Director29591090001
    DOWIE, Allan Cameron
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    Director
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinance Director132053460001
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director93041580001
    GARNER, Philip Frank
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    Director
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director48137730001
    HOBBS, David John
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishFinance Dir48318550001
    HOLLAND, Mark Harry
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    Director
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant98168130001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    Director
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    UsaAmericanDirector165775730001
    LODGE, Christopher Martin
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishOperations Director48087890001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    Director
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmericanBusiness Director61807850002
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishVice President Of Engineering12354670001
    ROWLEY, Stephen Nicholas
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    Director
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    BritishCompany Director47869520001
    SCHREIBER, Gregory
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    Director
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    AmericanPresident71227450001
    SOHAL, Balkar
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishChartered Accountant161546310001
    STRUDWICK, Tony
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    Director
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    BritishSales Director38754410001

    ¿Tiene UNION PUMP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture
    Creado el 24 sept 1992
    Entregado el 07 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 ref m*92. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 24 ene 1990
    Entregado el 06 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due frok each obligor to the chargee as agent & trustee for itself, the charges & for each b ank on any account whatsoever, under the terms of the financing documents (all terms as defined in a credit agreement dated 24.1.90)
    Breve descripción
    (For full details refer no doc 395 ref M98). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bankers Trust Company
    Transacciones
    • 06 may 1990Registro de una carga
    • 30 nov 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 24 ene 1990
    Entregado el 05 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor as defined in the charge as agent & trustee for itself & for each lender (as defined in the charge) on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Please see doc m 44 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • First Britannia Mezzanine Capital Bv
    Transacciones
    • 05 feb 1990Registro de una carga
    • 30 nov 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 jun 1989
    Entregado el 04 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jul 1989Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 27 jun 1989
    Entregado el 30 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jun 1989Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 20 dic 1985
    Entregado el 03 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See m 132). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 1986Registro de una carga
    Fixed and floating charge
    Creado el 18 oct 1985
    Entregado el 28 oct 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all f/h & l/h property all buildings, fixtures fixed plant & machinery all goodwill & un-called capital, all book & other debts. Floating charge over all undertaking and all property and assets present and future (see M131).
    Personas con derecho
    • First Wisconsin National Bank of Milwaukee
    Transacciones
    • 28 oct 1985Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 11 oct 1984
    Entregado el 26 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H chequers mann estate, carmore end, high wycombe buckinghamshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 oct 1984Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 26 sept 1984
    Entregado el 03 sept 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/L cobstone mill, ibstone bucks. As comprised in a conveyance dated 15/7/82.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 sept 1984Registro de una carga
    Deposit of deeds without written instrument
    Creado el 27 ago 1984
    Entregado el 12 sept 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Chequers manor estate cadmore end high wycombe buckinghamshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1984Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0