SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00368815 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SIX CONTINENTS HOTELS & HOLIDAYS LIMITED | 06 ago 2001 | 06 ago 2001 |
| BASS HOTELS AND HOLIDAYS LIMITED | 16 sept 1985 | 16 sept 1985 |
| BASS HOLIDAYS LIMITED | 27 nov 1984 | 27 nov 1984 |
| PONTIN'S LIMITED | 20 ago 1941 | 20 ago 1941 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 nov 2018 | 16 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Justin Bruce Robinson como director el 14 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 22 dic 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Haysmacintyre Company Secretaries Limited el 18 dic 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Patrick Thomas Mabry el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG el 18 dic 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Michael Teasdale el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 003688150004 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 05 oct 2017
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 03 feb 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| BOLTON, Susan | Secretario | 10 Haygreen Close KT2 7TS Kingston Upon Thames Surrey | British | 59426570001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| CRANE, Julia Alison | Secretario | 27 Hatton Court Lubbock Road BR7 5JQ Chislehurst Kent | British | 46318020001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Secretario | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Secretario | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203613510001 | |||||||||||
| TOON, Samantha Anne | Secretario | 10 St.Anthonys Court Nightingale Lane SW12 8NS London | British | 32930670001 | ||||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Secretario | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Secretario | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Ten Bishops Square E1 6EG London Eighth Floor United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CASTON, Robert Warwick | Director | Square De Heeus 20 FOREIGN 1400 Brussels Belgium | British | 1311840002 | ||||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Director | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Director | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| GRAHAM, Ian Christopher | Director | Avenue Venus 2 1410 Waterloo Belgium | British | 31551670001 | ||||||||||
| JACKMAN, Robert Loehr | Director | 4 Durning Place SL5 7EZ Ascot Berkshire | American | 35835670003 | ||||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Director | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Director | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| NEWMAN, Mark | Director | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PRINCE, Ryan David | Director | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| REES, Sally Irene | Director | 3 Sandown Gate KT10 9LB Esher Surrey | England | British | 49954790002 | |||||||||
| RITSON, Leslie David | Director | Old Middle Cator House Cator Widecombe In The Moor TQ13 7UA Newton Abbot Devonshire | British | 26098610002 | ||||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Director | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Director | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 | |||||||||
| VAN OOSTEROM, Sophie | Director | Orlando Road SW4 0LD London 19 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 139801070001 | |||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Director | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WINTER, Richard Thomas | Director | 33 St Johns Avenue Putney SW15 6AL London | United Kingdom | British | 6308500001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribbon Acquisition Limited | 06 abr 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 01 dic 2015 Entregado el 02 dic 2015 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 22 may 2013 Entregado el 03 jun 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 20 jun 2005 Entregado el 28 jun 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descripción L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 jun 2005 Entregado el 22 jun 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0