AMEC SPARECO (12) LIMITED

AMEC SPARECO (12) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAMEC SPARECO (12) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00381547
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AMEC BIRWELCO LIMITED24 oct 200024 oct 2000
    AGRA BIRWELCO LIMITED01 mar 199901 mar 1999
    BIRWELCO LIMITED18 feb 198718 feb 1987
    GKN BIRWELCO LIMITED06 jul 194306 jul 1943

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Jennifer Ann Warburton como secretario el 22 feb 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Helen Morrell como secretario el 22 feb 2017

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Helen Morrell como secretario el 22 jul 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Christopher Laskey Fidler como secretario el 22 jul 2016

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 jun 2016

    Estado de capital el 15 jun 2016

    • Capital: GBP 750,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    4 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 jun 2015

    Estado de capital el 15 jun 2015

    • Capital: GBP 750,000
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 jun 2014

    Estado de capital el 11 jun 2014

    • Capital: GBP 750,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    13 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mark Allen como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Amec Nominees Limited como director

    2 páginasAP02

    Déclaration annuelle établie au 08 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Renuncia del auditor

    4 páginasAUD

    Misceláneos

    Section 519
    3 páginasMISC

    ¿Quiénes son los directivos de AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WARBURTON, Jennifer Ann
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Secretario
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    225597720001
    LING, Grant Richmond
    The Academy
    16 Highgate Hill
    N19 5NS London
    Flat 24
    Director
    The Academy
    16 Highgate Hill
    N19 5NS London
    Flat 24
    EnglandBritish68935320003
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    England
    Director corporativo
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro374498
    32732300002
    ELLIOTT, David John
    Temple View
    Banner Lane, Barston
    B92 0JY Solihull
    Secretario
    Temple View
    Banner Lane, Barston
    B92 0JY Solihull
    British99771830001
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Secretario
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    MORRELL, Helen
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Secretario
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    210981190001
    RENSHAW, Geoffrey Mark
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    Secretario
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    British61351870001
    ALLEN, Mark Edward Hugh
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    Director
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    EnglandBritish148511740001
    AVENAS, Michel
    16 Rue Du Colonel Candelot
    92340 Bourg La Reine
    France
    Director
    16 Rue Du Colonel Candelot
    92340 Bourg La Reine
    France
    French36238710002
    BERARD, Jean-Paul
    1 Westmount Square
    Suite 650
    FOREIGN Montreal
    Quebec H32 2sr
    Canada
    Director
    1 Westmount Square
    Suite 650
    FOREIGN Montreal
    Quebec H32 2sr
    Canada
    French14302260001
    BIDDLE, Norman Michael, Dr
    The Chantry
    25 Church Road, Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    Director
    The Chantry
    25 Church Road, Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    United KingdomBritish35032440001
    CARTWRIGHT, Brian Harry
    Tannery Cottage Manchester Road
    Lostock Gralam
    CW9 7PJ Northwich
    Cheshire
    Director
    Tannery Cottage Manchester Road
    Lostock Gralam
    CW9 7PJ Northwich
    Cheshire
    British14302270001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    58 Bracken Road
    HX6 2HR Brighouse
    West Yorkshire
    Director
    58 Bracken Road
    HX6 2HR Brighouse
    West Yorkshire
    British107105790003
    CLARKE, John James
    Manor Close
    East Horsley
    KT24 6SB Leatherhead
    Dalehurst
    Surrey
    Director
    Manor Close
    East Horsley
    KT24 6SB Leatherhead
    Dalehurst
    Surrey
    United KingdomBritish150891000001
    COADY, Arthur Bernard
    79 Bel Air Place Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2z 2c3
    Canada
    Director
    79 Bel Air Place Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2z 2c3
    Canada
    Canadian14302210001
    COWPER, Jonathan
    2 Bluebell Close
    Etherley Dene
    DL14 0TL Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    2 Bluebell Close
    Etherley Dene
    DL14 0TL Bishop Auckland
    County Durham
    British124817460001
    DELIGNY, Jean Louis
    106 Avenue Emile Zola
    92100 Boulogne Billancourt
    France
    Director
    106 Avenue Emile Zola
    92100 Boulogne Billancourt
    France
    French45894430001
    DITTMER, Robert
    78 Sunset Way S E
    Calgary
    Alberta
    T2x 3c1
    Canada
    Director
    78 Sunset Way S E
    Calgary
    Alberta
    T2x 3c1
    Canada
    Canadian61292360003
    ELIA, Claudio
    40 Ridgeview Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Director
    40 Ridgeview Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Italian36238720001
    EMMANUEL, Derousseaux
    25 Rue St J B De La Salle
    Lille
    FOREIGN France 59000
    Director
    25 Rue St J B De La Salle
    Lille
    FOREIGN France 59000
    French60092120001
    GOURVENNEC, Michel Jean Jacques
    3151 Freeman Street
    Coconut Grove
    Florida 33133
    Usa
    Director
    3151 Freeman Street
    Coconut Grove
    Florida 33133
    Usa
    French41434270003
    HAEGEL, Didier Gerard Patrick
    13-15 Rue De 8 Mai 1945
    Villiers Sur Marne
    FOREIGN 94350 France
    Director
    13-15 Rue De 8 Mai 1945
    Villiers Sur Marne
    FOREIGN 94350 France
    French42856880001
    HIGGINS, Nigel Alan
    Conifers
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    Director
    Conifers
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish119181620001
    KENNEDY, Michael George
    34 Rue Numa Gillet
    77690 Montigny Sur Loing
    France
    Director
    34 Rue Numa Gillet
    77690 Montigny Sur Loing
    France
    British46681650001
    LANCEREAU, Alain Yves Marcel Andre
    51 Rue D Archeres
    Maisons Laffitte
    78600 France
    Director
    51 Rue D Archeres
    Maisons Laffitte
    78600 France
    French47515880001
    LEBRUN, Andre, Msr
    3 Avenue Stephane Mallarme
    Paris 75017
    FOREIGN France
    Director
    3 Avenue Stephane Mallarme
    Paris 75017
    FOREIGN France
    French34945510001
    LEE, Stephen Warwick
    The Barn
    Hildenley
    YO17 6QU Malton
    North Yorkshire
    Director
    The Barn
    Hildenley
    YO17 6QU Malton
    North Yorkshire
    British84186060002
    PATTERSON, Martin
    985 Clement
    FOREIGN Saint - Laurent
    Quebec H2v 3zx
    Canada
    Director
    985 Clement
    FOREIGN Saint - Laurent
    Quebec H2v 3zx
    Canada
    Canadian14302220001
    PEARSON, Harold William
    136 Avondale Court
    L7L2M8 Burlington
    Ontario
    Canada
    Director
    136 Avondale Court
    L7L2M8 Burlington
    Ontario
    Canada
    Canadian63588330001
    PFLEGER, Didier Maurice Christian
    Faubourg De Brisach
    90000 Belfort
    34
    France
    Director
    Faubourg De Brisach
    90000 Belfort
    34
    France
    French128722240001
    PRICE, John Leslie
    536 Coach Grove Road Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T3h 1j4
    Canada
    Director
    536 Coach Grove Road Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T3h 1j4
    Canada
    Canadian14302230001
    REALE, Robert J
    444 E86th St Apt 36f
    New York
    NY 10028 Usa
    Director
    444 E86th St Apt 36f
    New York
    NY 10028 Usa
    Us47515760001
    REDDEN, Charles Frederick David
    161 Woodpark Cx S W
    Calgary Alberta T2w 6es
    FOREIGN Canada
    Director
    161 Woodpark Cx S W
    Calgary Alberta T2w 6es
    FOREIGN Canada
    Canadian61291470001
    RENSHAW, Geoffrey Mark
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    Director
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    British61351870001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    06 abr 2016
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4612748
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene AMEC SPARECO (12) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment of insurance (the "assignment")
    Creado el 12 may 1999
    Entregado el 26 may 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of the company to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof
    Breve descripción
    The company assigns and transfers to the administrative agent all of its interests as insured under the policies of insurance described in the certificate of insurance attached as exhibit a to the assignment and under any and all policies issued in replacement of or in substitution for such policies or renewals of such policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The "Administrative Agent")
    Transacciones
    • 26 may 1999Registro de un cargo (395)
    Fixed and floating security document (the "security document")
    Creado el 12 may 1999
    Entregado el 26 may 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of such chargor to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The "Administrative Agent")
    Transacciones
    • 26 may 1999Registro de un cargo (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 01 dic 1998
    Entregado el 09 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Account number 57589055. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 22 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge
    Creado el 10 abr 1992
    Entregado el 28 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of any account(s) in the bank in name of the company.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 ago 1990
    Entregado el 24 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ago 1990Registro de una carga
    • 19 abr 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A credit agreement
    Creado el 15 mar 1990
    Entregado el 27 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurances particulars as from time to time varies or extended and the benefit of all power and remedies for cancelling and/or enforcing the same (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 27 mar 1990Registro de una carga
    Charge on book debts
    Creado el 06 sept 1989
    Entregado el 14 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts & other debts present & future the company's entire right, title , benefit & interest present & future in all debts and claims due or owing to the company under the contracts particulars of which are set out in the schedule on form 395 (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 14 sept 1989Registro de una carga
    Deed of assignment
    Creado el 22 feb 1989
    Entregado el 27 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All rights title benefit and interest under the contracts see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Banque Arake Et International I'investisement
    Transacciones
    • 27 feb 1989Registro de una carga
    Supplemental trust deed
    Creado el 16 may 1980
    Entregado el 25 may 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing debenture stock of guest keen and nettlefords (U.K.) LTD amounting to £3,509,390 supplemental to a trust deed dated 17-11-70 & deeds supplemental thereto
    Breve descripción
    Floating charge over the undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Assurance
    Transacciones
    • 25 may 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0