ROHAWK PROPERTIES LIMITED

ROHAWK PROPERTIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROHAWK PROPERTIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00381930
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 15 ago 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 27 jul 2023

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 19

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 22

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 23

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 24

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 30

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 31

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 16

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro8992198
    187856670001
    HAYMAN, Josephine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant266797860001
    TAUNT, Nick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant275050860001
    CHIA, Swee Ming
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    Secretario
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    BritishCertified Accountant57837290001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Secretario
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    British3470530003
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary251327820001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    CAFFARATE, Chrales Ernest John
    62 Cornwall Road
    Cheam
    SM2 6DS Sutton
    Surrey
    Director
    62 Cornwall Road
    Cheam
    SM2 6DS Sutton
    Surrey
    BritishChareterd Surveyor73954170001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    DAVIDSON, Emanuel Wolfe
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    Director
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    United KingdomBritishCompany Director3470540001
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Director
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritishSurveyor35563210002
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Director
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritishCompany Director35563210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Director
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    EnglandBritishChartered Accountant3470530003
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Secretariat226746900001
    JONES, Amanda Jane
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant73507000004
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    RANGER, Patrick
    2 Park Hill
    Ealing
    W5 2JR London
    Director
    2 Park Hill
    Ealing
    W5 2JR London
    EnglandBritishChartered Surveyor80021100001
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Director
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    ROBSON, Tom
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Accountant266793650001
    ROSCOE, Antony David
    54 Fowlers Walk
    W5 1BG London
    Director
    54 Fowlers Walk
    W5 1BG London
    BritishChartered Surveyor12774060001
    SCOTT, James Andrew
    13 Fairfield Lane
    SL2 3BX Farnham Royal
    Buckinghamshire
    Director
    13 Fairfield Lane
    SL2 3BX Farnham Royal
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor79599370001
    STEWART, David Purcell
    The Oast House Best Beech
    TN5 6JH Wadhurst
    East Sussex
    Director
    The Oast House Best Beech
    TN5 6JH Wadhurst
    East Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant56336720001
    WARD, Christopher Peter Alan
    36 Bacons Drive
    EN6 4DU Cuffley
    Hertfordshire
    Director
    36 Bacons Drive
    EN6 4DU Cuffley
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant80990890001
    WEBB, Nigel Mark
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bld Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro823907
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Bld Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies House 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene ROHAWK PROPERTIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 23 ene 1997
    Entregado el 29 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/a 55A lamont road london borough of kensington & chelsea t/n BGL18260 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 23 ene 1997
    Entregado el 29 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/a 55C lamont road london borough of kensington & chelsea t/n BGL18247 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 23 ene 1997
    Entregado el 29 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/a 9 adelaide court hill road st john's wood london borough of city of westminster t/n NGL742631 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 23 ene 1997
    Entregado el 28 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 30 yew tree court london NW11 all present and future book debts rents and licence fees the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 23 ene 1997
    Entregado el 28 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 11 yew tree court london NW11 present and future book and other debts by way of assignment the goodwill of the businessthe benefit of all guarantees rent and licence fees. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 23 ene 1997
    Entregado el 28 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 14 yew tree court london NW11 all present and future book debts,rents and licence fees,the benefit of all guarantees and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 23 ene 1997
    Entregado el 28 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 22 yew tree court london NW11 all book and other debts rents and licence fees by way of assignment the goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 23 ene 1997
    Entregado el 28 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 26 yew tree court london NW11 present and future book debts,goodwillthe benefit of all guarantees,shares. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 04 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    48 tavistock avenue st albans hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 04 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    18C vera road fulham london and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 04 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 3 courtleigh bridge lane golders green london NW11 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 04 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 5 barham house 39/40 molyneux street london N1 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 04 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    18E vera road fulham london and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 11 dic 1992
    Entregado el 21 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    99 silvermere road london borough of lewisham title no. Ln 108526.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 dic 1992
    Entregado el 21 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    2 wychwood avenue thornton heath london borough of croydon title no. Sgl 536736.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 11 dic 1992
    Entregado el 21 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    42 azof street london borough of greenwich title no. Sgl 320098.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 sept 1992
    Entregado el 02 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    52 moorland road st austell cornwall.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 sept 1992
    Entregado el 02 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    4,4A 6,6A 8,8A 10,10A 12,12A 14,14A 16,16A 18,18A 20,20A 22, and 22A castle view road weybridge and garages 1 to 8 (all) surrey title no: SY385694.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 02 sept 1992
    Entregado el 18 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 92 tynemouth road l/b of merton and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 02 sept 1992
    Entregado el 18 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 92 howard road woodside l/b of croydon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 02 sept 1992
    Entregado el 18 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    12 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555265 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 02 sept 1992
    Entregado el 18 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 18 belvedere court kings avenue clapham l/b of lambeth and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 02 sept 1992
    Entregado el 18 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 4 belvedere court kings avenue clapham l/b of lambeth and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 1993Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 02 sept 1992
    Entregado el 18 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    28 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555251 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 02 sept 1992
    Entregado el 18 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    35 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555244 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2022Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0