GL EVENTS UK LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GL EVENTS UK LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00392279 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GL EVENTS UK LIMITED?
- Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción
¿Dónde se encuentra GL EVENTS UK LIMITED?
Dirección de la sede social | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GL EVENTS UK LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
OWEN BROWN LIMITED | 06 abr 1992 | 06 abr 1992 |
OWEN.BROWN & SON(TENTS)LIMITED | 04 ene 1945 | 04 ene 1945 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GL EVENTS UK LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GL EVENTS UK LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 09 jul 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 23 jul 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 jul 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GL EVENTS UK LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 36 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 36 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Eric Rostagnat como director el 27 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 79 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de Gl Events Sa en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 35 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 dic 2016
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 35 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 dic 2016
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GL EVENTS UK LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK, Dan, Company Secretary | Secretario | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | 166133040001 | |||||||
APPY, Francois | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | France | French | Director | 77945810001 | ||||
BISHOP, Keith | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | United Kingdom | British | Director | 132720070001 | ||||
BLACK, Dan | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | United Kingdom | British | Finance Director | 166136260001 | ||||
GINON, Olivier | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | France | French | Director | 77945650001 | ||||
JAMESON, Scott William | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby Owen Brown Limited England | England | British | Managing Director | 183436250001 | ||||
ALLDREAD, Barry | Secretario | 37 Meeting House Close East Leake LE12 6HY Loughborough Leicestershire | British | 9731550001 | ||||||
BUNTING, Michael John | Secretario | 7 Main Street Ravenstone LE67 2AS Coalville Leicestershire | British | 14787210001 | ||||||
CHAPMAN, Michael Howard | Secretario | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | British | Director | 41716490001 | |||||
PRESTON, Elizabeth Ann | Secretario | 53 Park Lane Sutton Bonington LE12 5NQ Loughborough Leicestershire | British | 64200500001 | ||||||
TAYLOR, Christine Vivienne | Secretario | 2 Penfold Close Hathern LE12 5LS Loughborough Leicestershire | British | Company Accountant | 31684370001 | |||||
ANDERSON, James Douglas | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | England | British | Commercial Director | 179212010001 | ||||
BERTRAND, Damien | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | France | French | Director | 103533500001 | ||||
BUNTING, Michael John | Director | 7 Main Street Ravenstone LE67 2AS Coalville Leicestershire | British | Administration Executive | 14787210001 | |||||
CHAPMAN, Michael Howard | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | United Kingdom | British | Director | 41716490001 | ||||
DORRINGTON, Andrew Croot | Director | 12 The Willows Burton On The Wolds LE12 5AP Loughborough Leicestershire | New Zealand | Managing Director | 71926510002 | |||||
GOODE, John Owen Kenneth | Director | Charnwood Quakers Lane NG22 8EE Farnsfield Newark Nottinghamshire | British | Marquee Contractor | 35185540001 | |||||
HALL, Timothy | Director | 15 Long Croft Aston On Trent DE72 2UH Derby Derbyshire | British | Operations Director | 60567510002 | |||||
HAYWARD, Scott Vaughn | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | United Kingdom | British | Managing Director | 169151590001 | ||||
HAYWARD, Scott | Director | Dunsmore House Main Street, Leire LE17 5EU Leicester | British | Director | 119110200001 | |||||
HILL, Leslie James | Director | 16 Stanwick Court Thorpe Road PE3 6BW Peterborough Cambridgeshire | British | Marquee Hire Executive | 14843550001 | |||||
HOHN, Olivier | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | France | French | Director | 111547530001 | ||||
ILIFFE, Keith | Director | 22 Bramble Close Glenfield LE3 8JN Leicester | British | Business Development | 60567440002 | |||||
JACOB, Christopher Matthew | Director | Flat 2 10 Peverill Drive The Park Nottingham | British | Commercial Director | 29503300001 | |||||
MASCART, Bruno | Director | 20 Avenue Des Acacious FOREIGN Lyon 69003 France | French Australian | Director | 77945760001 | |||||
PRESTON, William John | Director | 53 Park Lane Sutton Bonnington LE12 5NQ Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | Sales & Mrketing Director | 14566080001 | ||||
PROVAN, Mitchell | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | England | British | Operations Director | 166960290001 | ||||
REYNOLDS, Ian | Director | 96 Kensington Gardens Carlton NG4 1DZ Nottingham | British | Commercial Director | 34226410001 | |||||
ROBERT, Denis | Director | 1421 Chemin Du Coutois Millery 69390 France | French | Director | 77945490001 | |||||
ROBERTSON, Alexander Richard Hay | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | England | British | Managing Director | 54837530001 | ||||
ROSTAGNAT, Eric | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | France | French | Director | 77945870001 | ||||
TRASLER, April Elizabeth | Director | 4 Kingston Court Kingston Fields Kingston On Soar NG11 0DL Nottingham | British | Contract Manager | 45894660002 | |||||
WOOD, Simon | Director | Station Road Castle Donington DE74 2NL Derby | United Kingdom | British | Operations Director | 156565770001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GL EVENTS UK LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gl Events Live Sa | 06 abr 2016 | Zi Nord Route D'Irigny Brignais, 69530 Zi Nord France | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene GL EVENTS UK LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 26 ene 2010 Entregado el 26 ene 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Credit agreement | Creado el 11 mar 1993 Entregado el 17 mar 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £77,712.40 | |
Breve descripción All its right title and interest in the insurance. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 24 nov 1992 Entregado el 02 dic 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 1 second drove fengate peterborough cambridgeshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 30 oct 1991 Entregado el 04 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & buildings on the east side of station rd, castle donington, north west leicestershire & the proceeds of sale thereof by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A credit agreement | Creado el 13 feb 1991 Entregado el 27 feb 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £33229-80 due from the company under the terms of the agreement | |
Breve descripción All its, rights, title and interest in and to all sums payable under the insurance (for more details see form 395 ref M342). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Credit agreement | Creado el 01 feb 1990 Entregado el 07 feb 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción All rights title interest in and to all sums payable under the insurance see form 395 (ref 340C) for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 10 ene 1990 Entregado el 17 ene 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £190,000 | |
Breve descripción Ims building bishop meadow road loughborough leicestershire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 04 jun 1982 Entregado el 09 jun 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Specific equitable charge over all f/h & l/h property and/or the proceeds of the sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 26 abr 1979 Entregado el 14 may 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Warehouse & premises bishops meadow rd, loughborough, leics LE11 0RQ.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 10 ene 1951 Entregado el 20 ene 1951 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £3,000 and further advances. | |
Breve descripción 38A sparrow hill, lough borough, leics 1 & 1A, hume street, and workshops adjoining laughborough. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0