MOVITEX (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMOVITEX (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00400458
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MOVITEX (UK) LIMITED?

    • Venta al por menor por correo o por Internet (47910) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra MOVITEX (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Rsm Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MOVITEX (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EMPIRE SHOPPER LIMITED05 feb 199005 feb 1990
    FRANK FATTORINI & SON LIMITED13 nov 194513 nov 1945

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MOVITEX (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MOVITEX (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    13 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 oct 2020

    15 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 oct 2019

    16 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 2 Holdsworth Street Bradford West Yorkshire BD1 4AH a Rsm Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 06 nov 2018

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 17 oct 2018

    LRESSP

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 16 mar 2018

    2 páginasPSC09

    Notification de Jean-Joel Huber en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC01

    Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Karen Hazeldine como director el 30 dic 2016

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2016 au 30 jun 2017

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    26 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 22 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 oct 2015

    Estado de capital el 22 oct 2015

    • Capital: GBP 600
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    21 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Karen Hazeldine como director el 25 mar 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 22 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 nov 2014

    Estado de capital el 20 nov 2014

    • Capital: GBP 600
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    21 páginasAA

    Cese del nombramiento de Michael Truluck como director el 04 ago 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 22 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 oct 2013

    Estado de capital el 25 oct 2013

    • Capital: GBP 600
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    21 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Roberts como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nathalie Balla como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de MOVITEX (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HUBER, Jean Joel
    Central Square 5th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Rsm Restructuring Advisory Llp
    Director
    Central Square 5th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Rsm Restructuring Advisory Llp
    FranceFrench176036030001
    MCLAUGHLIN, Ellen
    6 Wharfe Grove
    LS22 6HA Wetherby
    West Yorkshire
    Secretario
    6 Wharfe Grove
    LS22 6HA Wetherby
    West Yorkshire
    British125588610001
    OAKES, Frederick William, Mr.
    Tithe House Way
    HD2 1RD Huddersfield
    18
    West Yorkshire
    Secretario
    Tithe House Way
    HD2 1RD Huddersfield
    18
    West Yorkshire
    British2304400001
    BALLA, Nathalie Catherine
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    United Kingdom
    FranceFrench179486450001
    BAZIN, Pascal
    43 Bis, Avenue De La Marne
    Tourcoing
    59200
    France
    Director
    43 Bis, Avenue De La Marne
    Tourcoing
    59200
    France
    French79523170001
    BERNARD, Jean-Marc
    76 Rue Princesse
    Lille 59800
    FOREIGN France
    Director
    76 Rue Princesse
    Lille 59800
    FOREIGN France
    French66681090001
    BOTT, Richard
    49 Henley Avenue
    WF12 0LN Dewsbury
    West Yorkshire
    Director
    49 Henley Avenue
    WF12 0LN Dewsbury
    West Yorkshire
    British49293190001
    CAMBIER, Benoit Marie Joseph
    93 Bis Avenue Foch,
    Marcq En Baroeul
    59700
    France
    Director
    93 Bis Avenue Foch,
    Marcq En Baroeul
    59700
    France
    FranceFrench108923170001
    CAMPBELL, William James
    2 Heather Gardens
    Scarcroft
    LS14 3HU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    2 Heather Gardens
    Scarcroft
    LS14 3HU Leeds
    West Yorkshire
    British2303760001
    DEFOSSEZ, Alain
    74 Rue D'Hem
    Villeneuve D'Asco 59650
    FOREIGN France
    Director
    74 Rue D'Hem
    Villeneuve D'Asco 59650
    FOREIGN France
    French54304500001
    DEVE, Francoise Suzanne Marcelle
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    United Kingdom
    FranceFrench147082500001
    DUQUESNE, Pascal
    484 Terrace Fue Albert Bailly
    59700 Marcel En Baroeul
    France
    Director
    484 Terrace Fue Albert Bailly
    59700 Marcel En Baroeul
    France
    French54192810002
    GLARMET, Jean Pierre
    1 Rue Emile Gilbert
    FOREIGN Paris
    75012
    France
    Director
    1 Rue Emile Gilbert
    FOREIGN Paris
    75012
    France
    French66950500001
    GREEN, Marianne Mckenzie
    The Owl House 19 Eagle Row
    WA13 0PY Lymm
    Cheshire
    Director
    The Owl House 19 Eagle Row
    WA13 0PY Lymm
    Cheshire
    British118854820001
    HARRIS, Michael John Charles
    The Deri Bramhope Manor
    Moor Road Bramhope
    LS16 9HJ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    The Deri Bramhope Manor
    Moor Road Bramhope
    LS16 9HJ Leeds
    West Yorkshire
    British2307700001
    HAWKER, Michael Leslie
    Monkshorn
    East Boldre
    SO42 7WT Brockenhurst
    Hampshire
    Director
    Monkshorn
    East Boldre
    SO42 7WT Brockenhurst
    Hampshire
    United KingdomBritish114261580001
    HAZELDINE, Karen
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    Director
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    EnglandBritish196445560001
    HILL, Andrew Ratcliffe
    43 Park Lane
    Roundhay
    LS8 2EH Leeds
    West Yorkshire
    Director
    43 Park Lane
    Roundhay
    LS8 2EH Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish69640030001
    IZARD, Olivier Jacques Georges
    Creskeld House
    Creskeld Lane Arthington
    LS21 1NU Otley
    West Yorkshire
    Director
    Creskeld House
    Creskeld Lane Arthington
    LS21 1NU Otley
    West Yorkshire
    French87658610002
    JONES, Robert Glyn
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    Director
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    British116871110002
    JONVILLE, Jean-Luc
    594 Bois D'Achelles
    Bondues
    59910
    France
    Director
    594 Bois D'Achelles
    Bondues
    59910
    France
    French65053520001
    LUONG, Dominique
    78 Boulevard Du General De Gavlle
    Roubaix
    59100
    France
    Director
    78 Boulevard Du General De Gavlle
    Roubaix
    59100
    France
    French102340070001
    MADELEY, Jane Elisabeth
    102 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    Director
    102 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish105516350002
    OHLSSON, Hans
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomSwedish133656790001
    ROBERTS, Andrew William
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Holdsworth Street
    BD1 4AH Bradford
    2
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish68177770002
    ROCHE, Stephane Marie Marcel
    Hilly Ridge
    Grosvenor Road Headingley
    Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Hilly Ridge
    Grosvenor Road Headingley
    Leeds
    West Yorkshire
    French116192560002
    SKELSEY, Alistair James
    Bluebill Lodge
    79 Lower Mill Bank Triangle
    HX6 3ED Sowerby Bridge Halifax
    West Yorkshire
    Director
    Bluebill Lodge
    79 Lower Mill Bank Triangle
    HX6 3ED Sowerby Bridge Halifax
    West Yorkshire
    British74013420001
    THOMSON, Alan
    Flat 3
    Hamilton House, 4 Park Avenue
    HG2 9BQ Harrogate
    Director
    Flat 3
    Hamilton House, 4 Park Avenue
    HG2 9BQ Harrogate
    United KingdomBritish122421940001
    TRULUCK, Michael
    Kitty Fold
    Addingham
    LS29 0NB Ilkley
    1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Kitty Fold
    Addingham
    LS29 0NB Ilkley
    1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomSouth African153010590001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MOVITEX (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Monsieur Jean-Joel Huber
    Central Square 5th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Rsm Restructuring Advisory Llp
    06 abr 2016
    Central Square 5th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Rsm Restructuring Advisory Llp
    No
    Nacionalidad: French
    País de residencia: France
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para MOVITEX (UK) LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    22 oct 201607 nov 2017La empresa ha identificado a una persona registrable en relación con la empresa, pero no se han confirmado todos los datos requeridos de dicha persona.

    ¿Tiene MOVITEX (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Northern ireland deed of charge and assignment
    Creado el 28 oct 2003
    Entregado el 12 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all its right title and interest in and to the applicable charged monies and to the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Regency Assets Limited (The Participant)
    Transacciones
    • 12 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 17 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge and assignment
    Creado el 28 oct 2003
    Entregado el 12 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargor to the participant under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the applicable charged monies; the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Regency Assets Limited (The Participant)
    Transacciones
    • 12 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 17 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 nov 1990
    Entregado el 10 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from empire stores group PLC to the chargee as security agent for itself and the beneficiaries (as therein defined) underthe terms of the facility agreement and the facility letter both of even date
    Breve descripción
    Floating charge over (for full details see form 395 & schedule attached). Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Barclay De Zoette Wedd Limited
    Transacciones
    • 10 dic 1990Registro de una carga
    • 24 dic 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A fourth supplemental trust deed
    Creado el 27 nov 1990
    Entregado el 06 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Securing 6 3/8 per cent debenture stock 1985/ 90,8 3/4 percent debenture stock 1991/96 and 9 1/4 percent debenture stock 1994/99 created under the various trust deeds and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to royal exchange trust company limited as secured by this deed
    Breve descripción
    See doc M96 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transacciones
    • 06 dic 1990Registro de una carga
    • 29 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene MOVITEX (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 oct 2018Inicio de la liquidación
    18 ene 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gareth Harris
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    James Miller
    5th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    5th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0