MOVITEX (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MOVITEX (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00400458 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MOVITEX (UK) LIMITED?
- Venta al por menor por correo o por Internet (47910) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra MOVITEX (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Rsm Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MOVITEX (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EMPIRE SHOPPER LIMITED | 05 feb 1990 | 05 feb 1990 |
| FRANK FATTORINI & SON LIMITED | 13 nov 1945 | 13 nov 1945 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MOVITEX (UK) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MOVITEX (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 13 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 oct 2020 | 15 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 oct 2019 | 16 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Holdsworth Street Bradford West Yorkshire BD1 4AH a Rsm Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 06 nov 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 16 mar 2018 | 2 páginas | PSC09 | ||||||||||
Notification de Jean-Joel Huber en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Hazeldine como director el 30 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2016 au 30 jun 2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Karen Hazeldine como director el 25 mar 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Truluck como director el 04 ago 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Roberts como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nathalie Balla como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MOVITEX (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBER, Jean Joel | Director | Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Rsm Restructuring Advisory Llp | France | French | 176036030001 | |||||
| MCLAUGHLIN, Ellen | Secretario | 6 Wharfe Grove LS22 6HA Wetherby West Yorkshire | British | 125588610001 | ||||||
| OAKES, Frederick William, Mr. | Secretario | Tithe House Way HD2 1RD Huddersfield 18 West Yorkshire | British | 2304400001 | ||||||
| BALLA, Nathalie Catherine | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 179486450001 | |||||
| BAZIN, Pascal | Director | 43 Bis, Avenue De La Marne Tourcoing 59200 France | French | 79523170001 | ||||||
| BERNARD, Jean-Marc | Director | 76 Rue Princesse Lille 59800 FOREIGN France | French | 66681090001 | ||||||
| BOTT, Richard | Director | 49 Henley Avenue WF12 0LN Dewsbury West Yorkshire | British | 49293190001 | ||||||
| CAMBIER, Benoit Marie Joseph | Director | 93 Bis Avenue Foch, Marcq En Baroeul 59700 France | France | French | 108923170001 | |||||
| CAMPBELL, William James | Director | 2 Heather Gardens Scarcroft LS14 3HU Leeds West Yorkshire | British | 2303760001 | ||||||
| DEFOSSEZ, Alain | Director | 74 Rue D'Hem Villeneuve D'Asco 59650 FOREIGN France | French | 54304500001 | ||||||
| DEVE, Francoise Suzanne Marcelle | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 147082500001 | |||||
| DUQUESNE, Pascal | Director | 484 Terrace Fue Albert Bailly 59700 Marcel En Baroeul France | French | 54192810002 | ||||||
| GLARMET, Jean Pierre | Director | 1 Rue Emile Gilbert FOREIGN Paris 75012 France | French | 66950500001 | ||||||
| GREEN, Marianne Mckenzie | Director | The Owl House 19 Eagle Row WA13 0PY Lymm Cheshire | British | 118854820001 | ||||||
| HARRIS, Michael John Charles | Director | The Deri Bramhope Manor Moor Road Bramhope LS16 9HJ Leeds West Yorkshire | British | 2307700001 | ||||||
| HAWKER, Michael Leslie | Director | Monkshorn East Boldre SO42 7WT Brockenhurst Hampshire | United Kingdom | British | 114261580001 | |||||
| HAZELDINE, Karen | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 196445560001 | |||||
| HILL, Andrew Ratcliffe | Director | 43 Park Lane Roundhay LS8 2EH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 69640030001 | |||||
| IZARD, Olivier Jacques Georges | Director | Creskeld House Creskeld Lane Arthington LS21 1NU Otley West Yorkshire | French | 87658610002 | ||||||
| JONES, Robert Glyn | Director | 17 Wellington Lodge North Street Winkfield SL4 4TA Windsor Berkshire | British | 116871110002 | ||||||
| JONVILLE, Jean-Luc | Director | 594 Bois D'Achelles Bondues 59910 France | French | 65053520001 | ||||||
| LUONG, Dominique | Director | 78 Boulevard Du General De Gavlle Roubaix 59100 France | French | 102340070001 | ||||||
| MADELEY, Jane Elisabeth | Director | 102 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | England | British | 105516350002 | |||||
| OHLSSON, Hans | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Swedish | 133656790001 | |||||
| ROBERTS, Andrew William | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 68177770002 | |||||
| ROCHE, Stephane Marie Marcel | Director | Hilly Ridge Grosvenor Road Headingley Leeds West Yorkshire | French | 116192560002 | ||||||
| SKELSEY, Alistair James | Director | Bluebill Lodge 79 Lower Mill Bank Triangle HX6 3ED Sowerby Bridge Halifax West Yorkshire | British | 74013420001 | ||||||
| THOMSON, Alan | Director | Flat 3 Hamilton House, 4 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | United Kingdom | British | 122421940001 | |||||
| TRULUCK, Michael | Director | Kitty Fold Addingham LS29 0NB Ilkley 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | South African | 153010590001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MOVITEX (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Monsieur Jean-Joel Huber | 06 abr 2016 | Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Rsm Restructuring Advisory Llp | No |
Nacionalidad: French País de residencia: France | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para MOVITEX (UK) LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 22 oct 2016 | 07 nov 2017 | La empresa ha identificado a una persona registrable en relación con la empresa, pero no se han confirmado todos los datos requeridos de dicha persona. |
¿Tiene MOVITEX (UK) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Northern ireland deed of charge and assignment | Creado el 28 oct 2003 Entregado el 12 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge all its right title and interest in and to the applicable charged monies and to the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge and assignment | Creado el 28 oct 2003 Entregado el 12 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargor to the participant under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All its right title and interest in and to the applicable charged monies; the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 27 nov 1990 Entregado el 10 dic 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from empire stores group PLC to the chargee as security agent for itself and the beneficiaries (as therein defined) underthe terms of the facility agreement and the facility letter both of even date | |
Breve descripción Floating charge over (for full details see form 395 & schedule attached). Undertaking and all property and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A fourth supplemental trust deed | Creado el 27 nov 1990 Entregado el 06 dic 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Securing 6 3/8 per cent debenture stock 1985/ 90,8 3/4 percent debenture stock 1991/96 and 9 1/4 percent debenture stock 1994/99 created under the various trust deeds and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to royal exchange trust company limited as secured by this deed | |
Breve descripción See doc M96 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene MOVITEX (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0