RLP OLD CO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RLP OLD CO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00408816 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RLP OLD CO LIMITED?
- Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra RLP OLD CO LIMITED?
| Dirección de la sede social | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RLP OLD CO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ROBERTSON'S - LEDBURY PRESERVES LIMITED | 22 abr 1999 | 22 abr 1999 |
| LEDBURY PRESERVES LIMITED | 11 oct 1996 | 11 oct 1996 |
| INCHBROOK PENSION TRUSTEES LIMITED | 22 ene 1996 | 22 ene 1996 |
| HEINZEL (LONDON & VIENNA) LIMITED | 23 abr 1946 | 23 abr 1946 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RLP OLD CO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RLP OLD CO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Mcdonald como director el 23 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Duncan Neil Leggett como director el 23 may 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Emmett Mcevoy como director el 11 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Restauración por orden judicial | 5 páginas | AC92 | ||||||||||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed robertson's - ledbury preserves LIMITED\certificate issued on 11/06/12 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Antony Smith como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Emmett Mcevoy como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Mcdonald como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Suzanne Wise como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 34 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||||||
Aviso de eliminación de la restricción sobre los estatutos de la sociedad | 2 páginas | CC02 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Ms Suzanne Elizabeth Wise el 01 ago 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Simon Nicholas Wilbraham el 01 ago 2011 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RLP OLD CO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretario | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
| LEGGETT, Duncan Neil | Director | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 194179970001 | |||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Director | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | 125719290002 | |||||
| BROWN, Philip Damian | Secretario | 154 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 4JA Wokingham Berkshire | British | 120200002 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretario | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Secretario | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HINES, Christine Anne | Secretario | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Secretario | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretario | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Secretario | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| ALLNER, Andrew James | Director | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | 73003300001 | ||||||
| BOYD, James Macleod | Director | Wych Cottage Common Lane S42 7AN Cutthorpe Derbyshire | British | 21379830001 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Director | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Director | 42 Windmill Rise Kingston Hill KT2 7TU Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570001 | ||||||
| CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Director | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 98818450001 | |||||
| COOK, Bernard | Director | Flat C 1 Benbow Court Hammersmith W6 0AT London | British | 12836850001 | ||||||
| COURTNEY, Paul | Director | 9 Churchill Drive Newtown GL20 8EL Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | 222001800001 | |||||
| CROSSLEY, Nigel | Director | HP9 | England | British | 145901880001 | |||||
| HARDY, John | Director | 18 Turnpike Avenue GL12 7SD Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 49690000002 | ||||||
| HOLROYD, Dean | Director | 15 Clarence Square GL50 4JN Cheltenham Gloucestershire | British | 64875220001 | ||||||
| HUNTER, Muir Ian | Director | Fairhaven Akeferry Road Westwoodside DN9 2DS Doncaster South Yorkshire | British | 65861860001 | ||||||
| JOLLANS, Kenneth Richard | Director | Maple Heights Broad Street GL19 3BN Hartpury Gloucestershire | England | British | 73630340002 | |||||
| KELLY, Timothy Geoffrey | Director | The Mansion House Abbotts Inn SP11 7AU Andover Hampshire | England | British | 92817300001 | |||||
| LAWSON, Robert | Director | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | 99991140001 | |||||
| LEWIS, David | Director | Pennyfield 9 Pitch Pond Close Knotty Green HP9 1XY Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 69920630001 | |||||
| LEWIS, John | Director | Riseley Mill Cottage Risely Mill RG7 1XU Reading Berks | British | 21379850001 | ||||||
| MANN, Peter Charles | Director | 2 Orchard View Falfield GL12 8DG Wotton Under Edge Gloucestershire | England | British | 48283310001 | |||||
| MARCHANT, Richard Norman | Director | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Director | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Director | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| MCMAHON, Ian Reid | Director | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | 84644240002 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Director | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 120645920001 | |||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Director | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| PANTER, Alan James, Mr. | Director | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | 114414690002 |
¿Tiene RLP OLD CO LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 26 jul 2004 Entregado el 06 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Creado el 11 sept 2000 Entregado el 23 sept 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 29 abr 1986 Entregado el 14 may 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £54,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee. | |
Breve descripción Land and buildings at aber park flint clwyd. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 12 ene 1983 Entregado el 19 ene 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and buildings on the north side of bentley moor lane, adwick le street, doncaster. South yorkshire title no:- syk 72481. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 17 oct 1977 Entregado el 21 oct 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property under land title nos: syk 9008: syk 5509 syk 21732 in the county of south yorkshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 29 abr 1976 Entregado el 05 may 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future including book debts & goodwill uncalled capital. Fixed and floating charges see doc for further details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 17 oct 1974 Entregado el 24 oct 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & buildings at bentley moor lane, carcroft, doncaster, south yorkshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge on contract for sale | Creado el 17 oct 1974 Entregado el 24 oct 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Company's interest in a contract for sale dated 26.3.74 between adwick le street, urban district council and the company relating to land having a frontage to bentley moor lane, carcroft near doncaster, south yorkshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0