RLP OLD CO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRLP OLD CO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00408816
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RLP OLD CO LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra RLP OLD CO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RLP OLD CO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ROBERTSON'S - LEDBURY PRESERVES LIMITED22 abr 199922 abr 1999
    LEDBURY PRESERVES LIMITED11 oct 199611 oct 1996
    INCHBROOK PENSION TRUSTEES LIMITED22 ene 199622 ene 1996
    HEINZEL (LONDON & VIENNA) LIMITED23 abr 194623 abr 1946

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RLP OLD CO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RLP OLD CO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Andrew John Mcdonald como director el 23 may 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Duncan Neil Leggett como director el 23 may 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Emmett Mcevoy como director el 11 nov 2016

    1 páginasTM01

    Restauración por orden judicial

    5 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 oct 2012

    Estado de capital el 02 oct 2012

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed robertson's - ledbury preserves LIMITED\certificate issued on 11/06/12
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name11 jun 2012

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 11 jun 2012

    RES15
    change-of-name11 jun 2012

    Cambio de nombre por resolución

    NM01

    Cese del nombramiento de Antony Smith como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Emmett Mcevoy como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew Mcdonald como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Suzanne Wise como director

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Delete mem 07/10/2011
    RES13
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Aviso de eliminación de la restricción sobre los estatutos de la sociedad

    2 páginasCC02

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 01 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Ms Suzanne Elizabeth Wise el 01 ago 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Simon Nicholas Wilbraham el 01 ago 2011

    1 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de RLP OLD CO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish194179970001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BROWN, Philip Damian
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    British120200002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secretario
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretario
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretario
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secretario
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Director
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    BOYD, James Macleod
    Wych Cottage
    Common Lane
    S42 7AN Cutthorpe
    Derbyshire
    Director
    Wych Cottage
    Common Lane
    S42 7AN Cutthorpe
    Derbyshire
    British21379830001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    BURTON, Denise Patricia
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Director
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    COOK, Bernard
    Flat C 1 Benbow Court
    Hammersmith
    W6 0AT London
    Director
    Flat C 1 Benbow Court
    Hammersmith
    W6 0AT London
    British12836850001
    COURTNEY, Paul
    9 Churchill Drive
    Newtown
    GL20 8EL Tewkesbury
    Gloucestershire
    Director
    9 Churchill Drive
    Newtown
    GL20 8EL Tewkesbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritish222001800001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Director
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    HARDY, John
    18 Turnpike Avenue
    GL12 7SD Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Director
    18 Turnpike Avenue
    GL12 7SD Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British49690000002
    HOLROYD, Dean
    15 Clarence Square
    GL50 4JN Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    15 Clarence Square
    GL50 4JN Cheltenham
    Gloucestershire
    British64875220001
    HUNTER, Muir Ian
    Fairhaven Akeferry Road
    Westwoodside
    DN9 2DS Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    Fairhaven Akeferry Road
    Westwoodside
    DN9 2DS Doncaster
    South Yorkshire
    British65861860001
    JOLLANS, Kenneth Richard
    Maple Heights
    Broad Street
    GL19 3BN Hartpury
    Gloucestershire
    Director
    Maple Heights
    Broad Street
    GL19 3BN Hartpury
    Gloucestershire
    EnglandBritish73630340002
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Director
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Director
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    LEWIS, David
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish69920630001
    LEWIS, John
    Riseley Mill Cottage
    Risely Mill
    RG7 1XU Reading
    Berks
    Director
    Riseley Mill Cottage
    Risely Mill
    RG7 1XU Reading
    Berks
    British21379850001
    MANN, Peter Charles
    2 Orchard View
    Falfield
    GL12 8DG Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Director
    2 Orchard View
    Falfield
    GL12 8DG Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    EnglandBritish48283310001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Director
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Director
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish120645920001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Director
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002

    ¿Tiene RLP OLD CO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 26 jul 2004
    Entregado el 06 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 06 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Creado el 11 sept 2000
    Entregado el 23 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transacciones
    • 23 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 abr 1986
    Entregado el 14 may 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £54,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee.
    Breve descripción
    Land and buildings at aber park flint clwyd.
    Personas con derecho
    • Delyn Borough Council
    Transacciones
    • 14 may 1986Registro de una carga
    • 20 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 ene 1983
    Entregado el 19 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the north side of bentley moor lane, adwick le street, doncaster. South yorkshire title no:- syk 72481.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ene 1983Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 17 oct 1977
    Entregado el 21 oct 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property under land title nos: syk 9008: syk 5509 syk 21732 in the county of south yorkshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 1977Registro de una carga
    • 11 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 abr 1976
    Entregado el 05 may 1976
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts & goodwill uncalled capital. Fixed and floating charges see doc for further details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1976Registro de una carga
    • 27 may 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 oct 1974
    Entregado el 24 oct 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings at bentley moor lane, carcroft, doncaster, south yorkshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 oct 1974Registro de una carga
    • 21 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on contract for sale
    Creado el 17 oct 1974
    Entregado el 24 oct 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Company's interest in a contract for sale dated 26.3.74 between adwick le street, urban district council and the company relating to land having a frontage to bentley moor lane, carcroft near doncaster, south yorkshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 oct 1974Registro de una carga
    • 21 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0