WEW GROUP PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWEW GROUP PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 00410594
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WEW GROUP PLC?

    • (5212) /

    ¿Dónde se encuentra WEW GROUP PLC?

    Dirección de la sede social
    C/O Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WEW GROUP PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AMBER DAY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY15 may 194615 may 1946

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WEW GROUP PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WEW GROUP PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jun 2013

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    3 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 may 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 nov 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 may 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 nov 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 may 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 may 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 nov 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 may 2009

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 nov 2008

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 may 2008

    5 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de constitución del Comité de Liquidación

    2 páginas4.48

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    5 páginas4.68

    legacy

    1 páginas287

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    5 páginas4.68

    Notificación de la extinción de la orden de administración

    4 páginas2.19

    Resumen de ingresos y gastos del administrador

    2 páginas2.15

    Aviso de constitución del Comité de Liquidación

    2 páginas4.48

    Declaración de asuntos

    6 páginas4.20

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Resumen de ingresos y gastos del administrador

    2 páginas2.15

    Resumen de ingresos y gastos del administrador

    3 páginas2.15

    ¿Quiénes son los directivos de WEW GROUP PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KAYE, David Stanley
    3 Egidia Avenue
    Giffnock
    G46 7NH Glasgow
    Secretario
    3 Egidia Avenue
    Giffnock
    G46 7NH Glasgow
    BritishCompany Secretary78278710003
    VENTER, Daan
    17 Langside Road
    G71 8NG Bothwell
    Glasgow
    Director
    17 Langside Road
    G71 8NG Bothwell
    Glasgow
    South AfricanManaging Director79548370001
    PASKINS, Keith Terence
    The Orchard
    High Street
    SL6 0EX Taplow
    Berkshire
    Secretario
    The Orchard
    High Street
    SL6 0EX Taplow
    Berkshire
    British69289280001
    ROSE, David Stewart
    34 Ridgmount Street
    WC1E 7AA London
    Secretario
    34 Ridgmount Street
    WC1E 7AA London
    British67944820001
    THOMPSON, David Alan
    Barnfield House East Common
    AL5 1AW Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    Barnfield House East Common
    AL5 1AW Harpenden
    Hertfordshire
    British6462070001
    BARRIE, Michael Martin
    131 Fielding Road
    Chiswick
    W4 1DA London
    Director
    131 Fielding Road
    Chiswick
    W4 1DA London
    BritishCompany Director23536020001
    BOLAND, Richard Paul
    Hillfoot Cottage
    25 Uttoxeter Road
    WS15 3QR Hill Ridware Rugeley
    Staffordshire
    Director
    Hillfoot Cottage
    25 Uttoxeter Road
    WS15 3QR Hill Ridware Rugeley
    Staffordshire
    BritishCompany Director92472430001
    CARR, Peter Augustus Edward
    Church Road
    Great Cheverell
    SN10 5YA Devizes
    The Dutch House
    Wiltshire
    Director
    Church Road
    Great Cheverell
    SN10 5YA Devizes
    The Dutch House
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director131723320001
    COLES, Charles Graham
    Amerdale Lower Road
    Chorleywood
    WD3 5LB Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    Amerdale Lower Road
    Chorleywood
    WD3 5LB Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director12337010001
    ELLIS, Hugh David Stacey
    Woodsden
    Water Lane
    TN18 5AP Hawkhurst
    Kent
    Director
    Woodsden
    Water Lane
    TN18 5AP Hawkhurst
    Kent
    EnglandBritishCompany Director32401190002
    ELSON, Louis Goodman
    2 Kensington Gate
    W8 5NA London
    Director
    2 Kensington Gate
    W8 5NA London
    United KingdomUnited StatesFinance Executive46355150001
    GILLAN, Iain
    9 Yetholm Gardens
    Mavor Park Gardens
    G74 4GF East Kilbride
    Director
    9 Yetholm Gardens
    Mavor Park Gardens
    G74 4GF East Kilbride
    BritishDirector81116810001
    GRABINER, Ian Michael
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    Director
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director63235540002
    GRAY, Elaine
    3 Glebe Hollow
    Bothwell
    G71 8QX Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    3 Glebe Hollow
    Bothwell
    G71 8QX Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Director12718400001
    GREEN, Philip Nigel Ross, Sir
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    Director
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    United KingdomBritishCompany Director103945640001
    GUNTER, Kevin
    Braeriack 4 Upper Colquhoun Street
    G84 9AH Helensburgh
    Director
    Braeriack 4 Upper Colquhoun Street
    G84 9AH Helensburgh
    BritishRetail Operations55255580002
    HALL, Terence
    10 Park Drive
    Thorntonhall
    G74 5AS Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    10 Park Drive
    Thorntonhall
    G74 5AS Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Director65284500002
    HANSON, Bradley
    Flat 57 Huntsmore House
    Pembroke Road
    W8 London
    Director
    Flat 57 Huntsmore House
    Pembroke Road
    W8 London
    BritishVice President75101310001
    HOFFMAN, Alan Michael
    133 Hamilton Terrace
    NW8 9QR London
    Director
    133 Hamilton Terrace
    NW8 9QR London
    AmericanManaging Director60883410001
    MARRA, Francis Owen
    15 Hamilton Park North
    Duchess Park
    ML3 0FG Hamilton
    Lanarkshire
    Director
    15 Hamilton Park North
    Duchess Park
    ML3 0FG Hamilton
    Lanarkshire
    BritishCompany Director74876880002
    MILLAR, James Lauder
    30 Windsor Gardens
    PH3 1QE Auchterarder
    Perthshire
    Director
    30 Windsor Gardens
    PH3 1QE Auchterarder
    Perthshire
    BritishDirector138040003
    PASKINS, Keith Terence
    The Orchard
    High Street
    SL6 0EX Taplow
    Berkshire
    Director
    The Orchard
    High Street
    SL6 0EX Taplow
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director69289280001
    PRESTON, Desmond
    18 Doria Road
    SW6 4UG London
    Director
    18 Doria Road
    SW6 4UG London
    BritishConsultant145873570001
    RAMAGE, David Nicolson
    Kirkton Hill
    Ratho
    EH28 8RU Newbridge
    Midlothian
    Director
    Kirkton Hill
    Ratho
    EH28 8RU Newbridge
    Midlothian
    BritishDirector39207870001
    RIGBY, Martin Robert
    2 Craignethan Road
    Giffnock
    G46 6SQ Strathclyde
    Director
    2 Craignethan Road
    Giffnock
    G46 6SQ Strathclyde
    BritishManagement Consultant9515010001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South AfricanFinancial Director40527920003
    ROSE, David Stewart
    34 Ridgmount Street
    WC1E 7AA London
    Director
    34 Ridgmount Street
    WC1E 7AA London
    BritishCompany Director67944820001
    SHEARER, Owen
    54 Buchanan Drive
    Burnside
    G73 3PE Glasgow
    Director
    54 Buchanan Drive
    Burnside
    G73 3PE Glasgow
    BritishAccountant117000260001
    SHORTHOUSE, Dominic Hugh
    Lake House
    Lake Road
    GU25 4QW Virginia Water
    Surrey
    Director
    Lake House
    Lake Road
    GU25 4QW Virginia Water
    Surrey
    BritishInvestment Manager69592630003
    STASSEN, Carel
    West Acre Lodge
    Linton Lane
    LS22 6HG Wetherby
    Uk
    Director
    West Acre Lodge
    Linton Lane
    LS22 6HG Wetherby
    Uk
    South AfricanDirector104942950001
    THOMPSON, David Alan
    Barnfield House East Common
    AL5 1AW Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Barnfield House East Common
    AL5 1AW Harpenden
    Hertfordshire
    BritishFinance Director6462070001
    TIDEMAN, Christopher Charles Siddons
    40 Devonshire Place Mews
    W1N 1FJ London
    Director
    40 Devonshire Place Mews
    W1N 1FJ London
    BritishSelf Employed Consultant65470530001
    VINTON, Anna Marie
    37 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    Director
    37 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    BritishCompany Director7782310004
    VISSER, Johan Jacobus
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    South AfricanExecutive Director51820380002
    WALKER, Thomas Alexander Goldie
    Flat 2-1
    2 Burnside Gardens Giffnock
    Glasgow
    Director
    Flat 2-1
    2 Burnside Gardens Giffnock
    Glasgow
    BritishFinancial Director67798320001

    ¿Tiene WEW GROUP PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 16 mar 2000
    Entregado el 21 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Girobank PLC
    Transacciones
    • 21 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 09 dic 1999
    Entregado el 16 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Account charge and indemnity
    Creado el 08 oct 1997
    Entregado el 21 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or what everyone wants limited to the chargee (as from time to time modified, amended, renewed or extended) under (1) the facility letter and (2) the charge
    Breve descripción
    By way of specific charge all the right, title and interest of the company in each of the accounts and each of the deposits.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 sept 1997
    Entregado el 09 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 05 sept 1997
    Entregado el 12 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the floating charge
    Breve descripción
    By way of floating charge the whole of the property whatsoever and wheresoever which is or may be from time to time while the floating charge is in force, comprised in the property and underaking of the company including the uncalled capital for the time being.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creado el 20 ago 1997
    Entregado el 27 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums of money,liabilities and obligations due and that may become due in any manner of way from the company to the beneficiaries as defined in the said instrument
    Breve descripción
    All and whole the tenant's interest in the sub-lease between fine fare properties limited and wew group PLC dated 7 december 1994 and 11 january of the subjects on the ground floor and the first floor of the building shown delineated red on plans 2A and 2B annexed and signed as relative to the said sub-lease.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3 september 1997 and
    Creado el 29 jul 1997
    Entregado el 19 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and whole that area or piece of ground in the former burgh parish and county of inverness and now in the inverness district of the highland region and for the purpose of registration of writs in the county of inverness lying to the north west of strothers lane inverness. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security granted by the company in favour of the bank presented for registration in scotland on 29TH july 1997
    Creado el 29 jul 1997
    Entregado el 31 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Breve descripción
    All and whole the tenants interest in the subjects comprising unit 2 921 gallowgate glasgow t/no;-GLA123735.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security granted by the company in favour of the bank on 22ND july 1997 and presented for registration in scotland on 29TH july 1997
    Creado el 29 jul 1997
    Entregado el 31 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All and whole the tenant's interest in the subjects comprising the ground and upper floor premises being unit 4A pollok town centre glasgow t/no;-gla 71838.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security granted by the company in favour of the bank on 22ND july 1997 and presented for registration in scotland on 29TH july 1997
    Creado el 29 jul 1997
    Entregado el 31 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Breve descripción
    All and whole the tenants interest in the subjects comprising unit 8 new ashtree street development wishaw t/no;-AN45578.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 23 jul 1997
    Entregado el 02 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and what everyone wants limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Breve descripción
    43/45 ann street 47/55 upper church lane belfast new row coleraine unit 50 connswater centre belfast 45/51 mill street newry and unit 1 bryan street ballmena goodwill of any business at the property and benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 jul 1997
    Entregado el 24 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 17 jul 1997
    Entregado el 23 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The whole of the property whatsoever and wheresoever which is or may be from time to time comprised in the property of the company and undertaking including uncalled capital for the time being.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC; In Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries(As Defined)
    Transacciones
    • 23 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creado el 15 abr 1992
    Entregado el 29 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All rights moneys or property in respect of the deposited property and the mortgagor undertakes to lodge with the bank on receipt all document hereafter received by the mortgagor in relation to any such rights moneys or property as aforesaid.
    Personas con derecho
    • Bank Leumi (U.K.) PLC
    Transacciones
    • 29 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit charge
    Creado el 31 dic 1990
    Entregado el 08 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right, title, benefit & interest in a deposit account opened by the chargor with midland bank, 90 baker st. London W1 and designated " amber day blocked deposit account re: sm guarantee" together with all sums from time to time deposited therein (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transacciones
    • 08 ene 1991Registro de una carga
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of variation & supplemental charge
    Creado el 12 jul 1990
    Entregado el 20 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under a facility agreement dated 18/5/90, the mortgage debenture dated 6/6/90 and this charge.
    Breve descripción
    All right title and interest in the rights property and assets in the mortgage debenture (see form M395 ref M242).
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limited("the Agent")
    Transacciones
    • 20 jul 1990Registro de una carga
    • 13 dic 1991Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 15 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 06 jun 1990
    Entregado el 22 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Ground and 1ST floor part of l/h 362/364 oxford street london. Title no ngl 134019 (see form M395, ref M175 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Samuel Mortgage & Co. Limited
    Transacciones
    • 22 jun 1990Registro de una carga
    • 13 dic 1991Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 25 feb 1992Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 15 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of charge
    Creado el 06 jun 1990
    Entregado el 22 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an indemnity of even date.
    Breve descripción
    All its ritght title benefit and interest in the account whatsoever present and future (see form 395-ref m 174 for full details).
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limited.
    Transacciones
    • 22 jun 1990Registro de una carga
    • 17 jun 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Indemnity
    Creado el 06 jun 1990
    Entregado el 22 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 18TH may 1990.
    Breve descripción
    The proceeds of the rights issue of the borrower (see form 395-ref m 173 for full details).
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transacciones
    • 22 jun 1990Registro de una carga
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 mar 1986
    Entregado el 14 mar 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 615, chadwell industrial estate, kemp road, dagenham, london borough of barking and dagenham.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1986Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 06 jul 1983
    Entregado el 15 jul 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Right title and interest of the company securities of any kind (see doc M134).
    Personas con derecho
    • Charter House Japhet LTD
    Transacciones
    • 15 jul 1983Registro de una carga
    Further guarntee
    Creado el 10 ago 1982
    Entregado el 18 ago 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ago 1982Registro de una carga
    Guarantee & debenture
    Creado el 19 may 1982
    Entregado el 20 may 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Charged by the principal deed and further deed. Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Charterhouse Japhet Limited
    Transacciones
    • 20 may 1982Registro de una carga
    Charge of whole
    Creado el 15 jun 1981
    Entregado el 23 jun 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land known as no. 26 parklands drive, finchley london N3 title no. Ngl 189551.
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland Limited
    Transacciones
    • 23 jun 1981Registro de una carga
    Guarantee & debenture
    Creado el 19 feb 1980
    Entregado el 21 feb 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that property, undertaking of assets charged by the principal deed & further deed.
    Personas con derecho
    • Charter House Japhet LTD
    Transacciones
    • 21 feb 1980Registro de una carga

    ¿Tiene WEW GROUP PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 ene 2003Inicio de la administración
    11 jul 2006Administración dada por terminada
    Orden de administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Thomas Merchant Burton
    Ernst & Young Llp
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Profesional
    Ernst & Young Llp
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Garry Wilson
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Profesional
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    2
    FechaTipo
    25 may 2006Inicio de la liquidación
    08 oct 2013Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Profesional
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Thomas Merchant Burton
    Ernst & Young
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Profesional
    Ernst & Young
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0