WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED

WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWHELMAR (NORTH WALES) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00416042
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 abr 2025
    Próxima declaración de confirmación vence17 abr 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 abr 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024

    1 páginasTM01
    XDHVYVJU

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como secretario el 09 dic 2024

    1 páginasTM02
    XDHVYVHF

    Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024

    2 páginasAP01
    XDHVY9ZK

    Nombramiento de Mr Sayed Suleiman Ashrafi como secretario el 09 dic 2024

    2 páginasAP03
    XDHVX2DM

    Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024

    2 páginasAP01
    XD1U9QMW

    Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024

    1 páginasTM01
    XD1U9QHD

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XD09AU40

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    6 páginasAA
    ACXTUU54

    Cese del nombramiento de Molly Banham como secretario el 29 nov 2023

    1 páginasTM02
    XCHCMDKQ

    Nombramiento de Mr. Michael Andrew Lonnon como secretario el 29 nov 2023

    2 páginasAP03
    XCHCMDDL

    Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 01 sept 2023

    1 páginasTM01
    XCCMMB3V

    Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 01 sept 2023

    2 páginasAP01
    XCCMMB7K

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    6 páginasAA
    ACALOQYO

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XC0P79MI

    Cese del nombramiento de Alice Hannah Black como director el 26 ago 2022

    1 páginasTM01
    XBBHGHJU

    Nombramiento de Mr. Michael Andrew Lonnon como director el 26 ago 2022

    2 páginasAP01
    XBBHGHOX

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como secretario el 26 ago 2022

    1 páginasTM02
    XBBHGHQP

    Nombramiento de Miss Molly Banham como secretario el 26 ago 2022

    2 páginasAP03
    XBBHGHMP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    6 páginasAA
    AB7APWN5

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XB17W8FT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    6 páginasAA
    AA7RK6KQ

    Cambio de datos del director Miss Alice Hannah Marsden el 30 may 2021

    2 páginasCH01
    XA6UCE7V

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD03
    XA6M6IMB

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD02
    XA6BHJBE

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XA1WGDQX

    ¿Quiénes son los directivos de WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ASHRAFI, Sayed Suleiman
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    330347860001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary322288120001
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary330353690001
    BANHAM, Molly
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    299549580001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Secretario
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    INCE, David Norman
    Coombe Cottage 7 Cumbers Drive
    Ness
    L64 4AU South Wirral
    Secretario
    Coombe Cottage 7 Cumbers Drive
    Ness
    L64 4AU South Wirral
    British4915210003
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    316505950001
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British34521340004
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    British116824870001
    STOTE, Tanya
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    Secretario
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    British113603590001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193735640001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BELL, Paul
    9 Village Road
    Nannerch
    CH7 5RD Mold
    Clwyd
    Director
    9 Village Road
    Nannerch
    CH7 5RD Mold
    Clwyd
    BritishCompany Director5002530001
    BLACK, Alice Hannah
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor264031110002
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Director
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritishDirector76720550003
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary257671040002
    INCE, David Norman
    Coombe Cottage 7 Cumbers Drive
    Ness
    L64 4AU South Wirral
    Director
    Coombe Cottage 7 Cumbers Drive
    Ness
    L64 4AU South Wirral
    BritishCompany Director4915210003
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant8895880004
    JORDAN, James John
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary120602100002
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary34521340004
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Director
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant115863170001
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Director
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritishDirector75750250002
    SMITH, Ronald
    St Michaels
    Golly Burton Rossett
    LL12 0AH Wrexham
    Clwyd
    Director
    St Michaels
    Golly Burton Rossett
    LL12 0AH Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director5826110001
    TUTTE, John Frederick
    Peters Barn
    West End, Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Peters Barn
    West End, Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishChief Executive56012720002
    WATTS, Christopher Philip
    Halycon Lodge
    Field Close Ufton
    CV33 9PH Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    Halycon Lodge
    Field Close Ufton
    CV33 9PH Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishAccountant83391430001
    WILBY, Anthony
    The Waveney
    15 Leighton Road
    CH64 3SF Neston
    South Wirral
    Director
    The Waveney
    15 Leighton Road
    CH64 3SF Neston
    South Wirral
    BritishOperations Director93928430001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1986430
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Letter of offset
    Creado el 21 feb 1992
    Entregado el 02 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balances at credit of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 26 oct 1990
    Entregado el 10 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from wainhomes (lancashire) limited and/or wainhomes limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of whelmar (north wales) limited.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 nov 1990Registro de una carga
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 06 jun 1989
    Entregado el 12 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from wainhomes limited and/or wainhomes (lancashire) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    All sums now or hereafter at the credit of whelmar (north wales) limited's account or accounts.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 jun 1989Registro de una carga
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 18 oct 1988
    Entregado el 28 oct 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from whelmar developments limited and/or whelmar (chester) limited and/or cleveraim limited and/or whelmar group to the chargee.
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of whelmar (north wales) limited.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 oct 1988Registro de una carga
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 dic 1987
    Entregado el 11 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 dic 1987Registro de una carga
    • 19 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 dic 1986
    Entregado el 05 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 05 dic 1986Registro de una carga
    Charge
    Creado el 26 may 1966
    Entregado el 15 jun 1966
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land situate in abergele as comprised in a conveyance dated 14 oct 1964.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jun 1966Registro de una carga
    • 25 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 26 may 1966
    Entregado el 15 jun 1966
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land situate in abergele as comprised in a conveyance dated 14 oct 1964.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jun 1966Registro de una carga
    • 19 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0