WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00416042 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?
Dirección de la sede social | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 abr 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 17 abr 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 abr 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como secretario el 09 dic 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Sayed Suleiman Ashrafi como secretario el 09 dic 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Molly Banham como secretario el 29 nov 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr. Michael Andrew Lonnon como secretario el 29 nov 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 01 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Alice Hannah Black como director el 26 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr. Michael Andrew Lonnon como director el 26 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como secretario el 26 ago 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Miss Molly Banham como secretario el 26 ago 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 6 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Miss Alice Hannah Marsden el 30 may 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 páginas | AD03 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 páginas | AD02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHRAFI, Sayed Suleiman | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 330347860001 | |||||||
CANTY, Jennifer | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 322288120001 | ||||
HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 330353690001 | ||||
BANHAM, Molly | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 299549580001 | |||||||
HASTINGS, Jonathan Philip | Secretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
INCE, David Norman | Secretario | Coombe Cottage 7 Cumbers Drive Ness L64 4AU South Wirral | British | 4915210003 | ||||||
LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 316505950001 | |||||||
LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | British | 34521340004 | ||||||
NUNN, Carol Jayne | Secretario | 4 Juniper Close NN12 6XP Towcester Northamptonshire | British | 116824870001 | ||||||
STOTE, Tanya | Secretario | Honeyburge The Fordrough B90 1PP Solihull West Midlands | British | 113603590001 | ||||||
ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Director | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 193735640001 | ||||
ANDREW, Peter Robert | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Regional Managing Director | 113503830003 | ||||
BELL, Paul | Director | 9 Village Road Nannerch CH7 5RD Mold Clwyd | British | Company Director | 5002530001 | |||||
BLACK, Alice Hannah | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 264031110002 | ||||
CARNEY, Christopher | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 125216670001 | ||||
CLAPHAM, Colin Richard | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 9684390001 | ||||
GREEN, Robert David | Director | 11 Whitworth Lane Loughton MK5 8EB Milton Keynes | England | British | Director | 76720550003 | ||||
HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 257671040002 | ||||
INCE, David Norman | Director | Coombe Cottage 7 Cumbers Drive Ness L64 4AU South Wirral | British | Company Director | 4915210003 | |||||
JOHNSON, Peter Thomas | Director | 34 Homewood Road AL1 4BQ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 8895880004 | ||||
JORDAN, James John | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Secretary | 120602100002 | ||||
LONNON, Michael Andrew, Mr. | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 34521340004 | ||||
MURRIN, Jonathan Charles | Director | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | Chartered Accountant | 115863170001 | |||||
PEACOCK, Raymond Anthony | Director | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | Director | 75750250002 | ||||
SMITH, Ronald | Director | St Michaels Golly Burton Rossett LL12 0AH Wrexham Clwyd | British | Company Director | 5826110001 | |||||
TUTTE, John Frederick | Director | Peters Barn West End, Scaldwell NN6 9JX Northampton Northamptonshire | England | British | Chief Executive | 56012720002 | ||||
WATTS, Christopher Philip | Director | Halycon Lodge Field Close Ufton CV33 9PH Leamington Spa Warwickshire | British | Accountant | 83391430001 | |||||
WILBY, Anthony | Director | The Waveney 15 Leighton Road CH64 3SF Neston South Wirral | British | Operations Director | 93928430001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mclean Tw Limited | 06 abr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene WHELMAR (NORTH WALES) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Letter of offset | Creado el 21 feb 1992 Entregado el 02 mar 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The balances at credit of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Letter of offset | Creado el 26 oct 1990 Entregado el 10 nov 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from wainhomes (lancashire) limited and/or wainhomes limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of whelmar (north wales) limited. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Letter of offset | Creado el 06 jun 1989 Entregado el 12 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from wainhomes limited and/or wainhomes (lancashire) limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción All sums now or hereafter at the credit of whelmar (north wales) limited's account or accounts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Letter of offset | Creado el 18 oct 1988 Entregado el 28 oct 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from whelmar developments limited and/or whelmar (chester) limited and/or cleveraim limited and/or whelmar group to the chargee. | |
Breve descripción The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of whelmar (north wales) limited. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 11 dic 1987 Entregado el 11 dic 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed and floating charge | Creado el 03 dic 1986 Entregado el 05 dic 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 26 may 1966 Entregado el 15 jun 1966 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land situate in abergele as comprised in a conveyance dated 14 oct 1964. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 26 may 1966 Entregado el 15 jun 1966 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land situate in abergele as comprised in a conveyance dated 14 oct 1964. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0