W T SEYMOUR LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaW T SEYMOUR LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00420431
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de W T SEYMOUR LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra W T SEYMOUR LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de W T SEYMOUR LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    W.T.SEYMOUR(STOCKTON)LIMITED28 sept 194628 sept 1946

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de W T SEYMOUR LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el28 feb 2011
    Próximas cuentas vencen el30 nov 2011
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta25 feb 2010

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para W T SEYMOUR LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta13 ago 2016
    Próxima declaración de confirmación vence27 ago 2016
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para W T SEYMOUR LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para W T SEYMOUR LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Restauración por orden judicial

    4 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Simon Terence Douglas como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Simon Terence Douglas como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philip Bowcock como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ago 2011

    Estado de capital el 18 ago 2011

    • Capital: GBP 4,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Philip Hedley Bowcock como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Jayne Fearn como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 feb 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Andrew Marks como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Luminar Leisure Limited como director

    2 páginasAP02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 feb 2009

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2008

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2007

    7 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 mar 2006

    8 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de W T SEYMOUR LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FEARN, Jayne
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Secretario
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    158809780001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Director corporativo
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro03802937
    152133330001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Secretario
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    COLLEDGE, David Ingram
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    Secretario
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    British9330890001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Secretario
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Secretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Secretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Secretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Director
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Director
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Director
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Director
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Director
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    COLLEDGE, David Ingram
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    Director
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    United KingdomBritish9330890001
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Director
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MCCULLOCH, John James
    21 Manor Place
    Fairfield
    TS19 7HF Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    21 Manor Place
    Fairfield
    TS19 7HF Stockton On Tees
    Cleveland
    EnglandBritish31008980001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Director
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Director
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WELSH, James Michael
    Thackwoods The Mains
    Giggleswick
    BD24 0AX Settle
    North Yorkshire
    Director
    Thackwoods The Mains
    Giggleswick
    BD24 0AX Settle
    North Yorkshire
    British9330900002
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Director
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    HANOVER THREE LIMITED
    41 King Street
    LU1 2DW Luton
    Bedfordshire
    Director corporativo
    41 King Street
    LU1 2DW Luton
    Bedfordshire
    62089160004

    ¿Tiene W T SEYMOUR LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 08 feb 1995
    Entregado el 23 feb 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 feb 1995Registro de un cargo (395)
    Letter of offset
    Creado el 19 sept 1990
    Entregado el 04 oct 1990
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due from truscott engineering limited to the governor and company of the bank of scotland
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 oct 1990Registro de una carga
    Letter of offset
    Creado el 21 nov 1989
    Entregado el 11 dic 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from fife indmar PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts. Held by the governor and company of the bank of scotland.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 dic 1989Registro de una carga
    Letter of offset
    Creado el 17 ago 1982
    Entregado el 03 sept 1982
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from T.S. forster & sons limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 sept 1982Registro de una carga
    Letter of offset
    Creado el 19 mar 1982
    Entregado el 08 abr 1982
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from park naval engineering limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit on any account on accounts of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 abr 1982Registro de una carga
    Letter of offset
    Creado el 27 feb 1981
    Entregado el 18 mar 1981
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from robt. Balbirnie & company limited and/or henry nuttall (rochdale) limited to the chargee
    Breve descripción
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 mar 1981Registro de una carga
    Letter of set off
    Creado el 28 mar 1979
    Entregado el 11 abr 1979
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    Securing all monies due or to become due from W.l buyers & co lef bishop LTD. Fife forge co LTD fife forster LTD crompton & harrison LTD. Thompson brothers to the chargee.
    Breve descripción
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 abr 1979Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0