GORSEY SIX LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGORSEY SIX LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00421037
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GORSEY SIX LIMITED?

    • (5212) /

    ¿Dónde se encuentra GORSEY SIX LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GORSEY SIX LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ECLIPSE BLINDS LIMITED14 jul 199414 jul 1994
    ASHLEY GROUP PLC09 sept 198809 sept 1988
    ASHLEY INDUSTRIAL TRUST P L C31 dic 197931 dic 1979
    THAMES PLYWOOD MANUFACTURERS LIMITED07 oct 194607 oct 1946

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GORSEY SIX LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2005

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GORSEY SIX LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 jun 2010

    5 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Restructuring 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL el 22 dic 2009

    1 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 dic 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 jun 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 dic 2008

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 dic 2008

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    5 páginas4.68

    legacy

    1 páginas287

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    13 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2004

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginas363s

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2003

    15 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2002

    15 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2001

    16 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed eclipse blinds LIMITED\certificate issued on 01/10/02
    2 páginasCERTNM

    ¿Quiénes son los directivos de GORSEY SIX LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DUGGAN, Geoffrey Michael
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    British9962100001
    BREWER, Anthony John
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    Director
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    EnglandBritish28937370012
    WILSON, Stephen Graham
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    Director
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish23638320002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secretario
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    GILLIES, Malcolm John
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    Secretario
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    British1381960001
    STABLES, Jane Margaret
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    Secretario
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    British41059230001
    ANDERSON, Thomas James
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    Director
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    British57834870001
    BLACK, James Edward
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    Director
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    ScotlandUnited Kingdom35816690001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Director
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    BUTLER, Anthony Bertram
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    Director
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    British18439630001
    GROSSART, Hamish Mcleod
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    Director
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    British37900003
    IRVINE, John Christopher
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    Director
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    British38442060001
    JOHN, Christopher
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    British71834620003
    KIRKHAM, Ian
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    Director
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    British34964530002
    LANGLANDS, John Thomson
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    Director
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    ScotlandBritish722090001
    LARMAN, Trevor George
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    England/HertfordshireBritish10878930001
    MACDONALD, William
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    Director
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    British539830001
    MAYDON, Peter John
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    Director
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish5988360001
    MCNEIL, Robert
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    Director
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish31415950001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Director
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MONSERRAT MESANZA, Miguel
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Director
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945210001
    ORTON, Anthony Stanley
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    Director
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    British Canadian12605660001
    RODGER, James Roy
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Director
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British48535040002
    THOMAS, John Alan
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    British802790001
    TIPPER, Christopher Stuart
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    Director
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    British46918370001
    URCELAY ALONSO, Antonio
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Director
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945230001
    WHITE, James
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    British28464050001

    ¿Tiene GORSEY SIX LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 29 nov 1995
    Entregado el 08 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 26 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 nov 1995
    Entregado el 02 dic 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 dic 1995Registro de un cargo (395)
    A deed of charge
    Creado el 30 jun 1994
    Entregado el 18 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement dated 27 april 1989 as amended by a minute of variation dated of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994
    Breve descripción
    (1) 46,906 ordinary shares of £1 each in the capital of vertika international limited and 250,000 ordinary shares of £1 each in the capital of british plywood manufacturers limited (2) the derivative assets and (3) all dividends, interest and other income deriving from the shares or any derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • James Mcneil
    Transacciones
    • 18 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of charge
    Creado el 30 jun 1994
    Entregado el 18 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Breve descripción
    The chargor as beneficial owner as continuing security for the payment of the secured obligations, has charged in favour of the creditor by way of floating charge. (A) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accuring on or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime attaching to, or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • James Mcneil
    Transacciones
    • 18 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of charge
    Creado el 30 jun 1994
    Entregado el 18 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement of 27 april 1989 as amrnded by a minute of variation of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Breve descripción
    All dividends interest and other income at any time hereafter deriving from the shares or any derivative assets or deriving from any investment of any such dividends interest or other income. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Robert Mcneil
    Transacciones
    • 18 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of charge
    Creado el 30 jun 1994
    Entregado el 18 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Breve descripción
    By way of floating charge (a) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accruing on, or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime ataching to or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Robert Mcneil
    Transacciones
    • 18 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 03 sept 1993
    Entregado el 10 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge (a) the securities; and (b) all moneys and assets in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at any time (for full details of charge see form 395).
    Personas con derecho
    • Secured Parties (As Defined).
    Transacciones
    • 10 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment agreement
    Creado el 31 ago 1988
    Entregado el 05 sept 1988
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88 and this assignment
    Breve descripción
    All the company's right, title and interest (see form 395 for full details, ref : M50).
    Personas con derecho
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    Transacciones
    • 05 sept 1988Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 31 ago 1988
    Entregado el 05 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88, assignment agreement dated 31/8/88 and this charge
    Breve descripción
    (See form 395 for full details ref: M52). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    Transacciones
    • 05 sept 1988Registro de una carga
    • 12 mar 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GORSEY SIX LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 nov 2010Fecha de disolución
    08 dic 2006Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profesional
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Profesional
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0