LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00422897 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo al transporte (52290) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | One Strand Trafalgar Square WC2N 5HR London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GIBBONS FREIGHT (NEWCASTLE) LTD. | 27 may 1998 | 27 may 1998 |
| NEI BRANTFORD INTERNATIONAL LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| HEAT EXCHANGERS LIMITED | 02 nov 1946 | 02 nov 1946 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 17 oct 2018
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Louise Margaret Evans como director el 29 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Peter Timothy James Mason como secretario el 17 nov 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Claremont Buildings Old Clatterbridge Road Bebington Wirral Merseyside CH63 4JB a One Strand Trafalgar Square London WC2N 5HR el 27 nov 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander Chandos Tempest Vane como director el 17 nov 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Richard De Villeneuve Kidwell como director el 15 nov 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Louise Margaret Evans como director el 15 nov 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander Chandos Tempest Vane como secretario el 18 ago 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alexander Chandos Tempest Vane como director el 09 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tracy Ann Harman como director el 09 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alexander Chandos Tempest Vane como secretario el 27 ene 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Raine como secretario el 27 ene 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 29 feb 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASON, Peter Timothy James | Secretario | Trafalgar Square WC2N 5HR London One Strand United Kingdom | 240588130001 | |||||||
| KIDWELL, James Richard De Villeneuve | Director | Trafalgar Square WC2N 5HR London One Strand United Kingdom | United Kingdom | British | 228137430001 | |||||
| CAVE, Michael Brian | Secretario | 42 St Georges Avenue RM17 5XB Grays Essex | British | 47952190001 | ||||||
| DARBY, Neil Sidney | Secretario | 5 Martingale Close CM11 1SQ Billericay Essex | British | 64235430002 | ||||||
| HOPKINSON, Jeremy Mark | Secretario | Owl Cottage 42 Vicarage Lane Grasby DN38 6AU Barnetby Lincolnshire | British | 22385830001 | ||||||
| RAINE, Christopher | Secretario | Old Clatterbridge Road Bebington CH63 4JB Wirral Claremont Buildings Merseyside United Kingdom | British | 21089060005 | ||||||
| VANE, Alexander Chandos Tempest | Secretario | Old Clatterbridge Road Bebington CH63 4JB Wirral Claremont Buildings Merseyside | 223445630001 | |||||||
| WARREN, John Emmerson | Secretario | 1 Gellesfield Chare Whickham NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne | British | 796200001 | ||||||
| BALE, David Randal | Director | High Riding Aydon Road NE45 5EJ Corbridge Northumberland | British | 18874500001 | ||||||
| BROWN, Derek | Director | 32 Hastings Avenue NE26 4AF Whitley Bay Tyne & Wear | British | 26977460001 | ||||||
| BROWN, Robert Smith | Director | 2 Amesbury Close Abbey Grange NE5 1PY North Walbottle Newcastle Upon Tyne | British | 26554410002 | ||||||
| CAVE, Michael Brian | Director | 42 St Georges Avenue RM17 5XB Grays Essex | British | 47952190001 | ||||||
| CONE, Harry Douglas | Director | 5 The Orchard Hepscott NE61 6HT Morpeth Northumberland | British | 796210001 | ||||||
| CONSTANTINE, Robert Loudon | Director | Hayne Old Manor Moreton Hampstead TQ13 8SB Newton Abbot Devon | British | 35908860001 | ||||||
| DARBY, Neil Sidney | Director | Old Clatterbridge Road Bebington CH63 4JB Wirral Claremont Buildings Merseyside United Kingdom | England | British | 64235430002 | |||||
| EVANS, Louise Margaret | Director | Trafalgar Square WC2N 5HR London One Strand United Kingdom | United Kingdom | British | 164439180002 | |||||
| GOWER, Kenneth Stanley | Director | 11 Round Ash Way Hartley DA3 8BT Longfield Kent | British | 30104950001 | ||||||
| GREEN, Michael Robert | Director | Cory House 21 Berth Tilbury Docks RM18 7JT Tilbury Essex | United Kingdom | British | 50520570001 | |||||
| HARMAN, Tracy Ann | Director | Old Clatterbridge Road Bebington CH63 4JB Wirral Claremont Buildings Merseyside United Kingdom | England | British | 195416610001 | |||||
| HARRISON, Michael James | Director | 3 Caldecote Close ME8 8TP Rainham Kent | England | British | 54184950001 | |||||
| OVERSTALL, Charles Andrew | Director | Carkin East Layton DL11 7PE Richmond North Yorkshire | British | 53604540001 | ||||||
| RAINE, Christopher | Director | 6 Eastfield Road, Noak Bridge Laindon SS15 4JE Basildon Essex | British | 21089060005 | ||||||
| RAISTRICK, George | Director | 12 Weston Avenue Fellside Park NE16 5TS Whickham Newcastle Upon Tyne | British | 9839400001 | ||||||
| ROBINSON, Frank William | Director | 33 Sebastian Avenue Shenfield CM15 8PW Brentwood Essex | British | 2664580001 | ||||||
| RUSSELL, James | Director | 21 Fontburn Amble NE65 0BL Morpeth Northumberland | British | 39082080001 | ||||||
| TODD, Alan Russell | Director | Hathaway Grosvenor Road GU7 1PA Godalming Surrey | British | 12344090001 | ||||||
| VANE, Alexander Chandos Tempest | Director | Old Clatterbridge Road Bebington CH63 4JB Wirral Claremont Buildings Merseyside | England | British | 131374740001 | |||||
| WOOD, Terence | Director | 78 Littleover Lane DE23 6JG Derby Derbyshire | British | 13931780001 | ||||||
| YEOMAN, Campbell | Director | 1 The Barkery Newby TS8 0AW Middlesbrough Cleveland | British | 12303640001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cb Newcastle Limited | 06 abr 2016 | Old Clatterbridge Road CH63 4JB Wirral Claremont Buildings United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 27 ago 2004 Entregado el 04 sept 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0