LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED

LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00422897
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo al transporte (52290) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    One Strand
    Trafalgar Square
    WC2N 5HR London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GIBBONS FREIGHT (NEWCASTLE) LTD.27 may 199827 may 1998
    NEI BRANTFORD INTERNATIONAL LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    HEAT EXCHANGERS LIMITED02 nov 194602 nov 1946

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 17 oct 2018

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Louise Margaret Evans como director el 29 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2017

    3 páginasAA

    Nombramiento de Peter Timothy James Mason como secretario el 17 nov 2017

    2 páginasAP03

    Domicilio social registrado cambiado de Claremont Buildings Old Clatterbridge Road Bebington Wirral Merseyside CH63 4JB a One Strand Trafalgar Square London WC2N 5HR el 27 nov 2017

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Alexander Chandos Tempest Vane como director el 17 nov 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr James Richard De Villeneuve Kidwell como director el 15 nov 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Miss Louise Margaret Evans como director el 15 nov 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alexander Chandos Tempest Vane como secretario el 18 ago 2017

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Alexander Chandos Tempest Vane como director el 09 may 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Tracy Ann Harman como director el 09 may 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Alexander Chandos Tempest Vane como secretario el 27 ene 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Christopher Raine como secretario el 27 ene 2017

    1 páginasTM02

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 29 feb 2016

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 may 2016

    Estado de capital el 26 may 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASON, Peter Timothy James
    Trafalgar Square
    WC2N 5HR London
    One Strand
    United Kingdom
    Secretario
    Trafalgar Square
    WC2N 5HR London
    One Strand
    United Kingdom
    240588130001
    KIDWELL, James Richard De Villeneuve
    Trafalgar Square
    WC2N 5HR London
    One Strand
    United Kingdom
    Director
    Trafalgar Square
    WC2N 5HR London
    One Strand
    United Kingdom
    United KingdomBritish228137430001
    CAVE, Michael Brian
    42 St Georges Avenue
    RM17 5XB Grays
    Essex
    Secretario
    42 St Georges Avenue
    RM17 5XB Grays
    Essex
    British47952190001
    DARBY, Neil Sidney
    5 Martingale Close
    CM11 1SQ Billericay
    Essex
    Secretario
    5 Martingale Close
    CM11 1SQ Billericay
    Essex
    British64235430002
    HOPKINSON, Jeremy Mark
    Owl Cottage 42 Vicarage Lane
    Grasby
    DN38 6AU Barnetby
    Lincolnshire
    Secretario
    Owl Cottage 42 Vicarage Lane
    Grasby
    DN38 6AU Barnetby
    Lincolnshire
    British22385830001
    RAINE, Christopher
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    United Kingdom
    Secretario
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    United Kingdom
    British21089060005
    VANE, Alexander Chandos Tempest
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    Secretario
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    223445630001
    WARREN, John Emmerson
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    British796200001
    BALE, David Randal
    High Riding Aydon Road
    NE45 5EJ Corbridge
    Northumberland
    Director
    High Riding Aydon Road
    NE45 5EJ Corbridge
    Northumberland
    British18874500001
    BROWN, Derek
    32 Hastings Avenue
    NE26 4AF Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Director
    32 Hastings Avenue
    NE26 4AF Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British26977460001
    BROWN, Robert Smith
    2 Amesbury Close
    Abbey Grange
    NE5 1PY North Walbottle
    Newcastle Upon Tyne
    Director
    2 Amesbury Close
    Abbey Grange
    NE5 1PY North Walbottle
    Newcastle Upon Tyne
    British26554410002
    CAVE, Michael Brian
    42 St Georges Avenue
    RM17 5XB Grays
    Essex
    Director
    42 St Georges Avenue
    RM17 5XB Grays
    Essex
    British47952190001
    CONE, Harry Douglas
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    Director
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    British796210001
    CONSTANTINE, Robert Loudon
    Hayne Old Manor
    Moreton Hampstead
    TQ13 8SB Newton Abbot
    Devon
    Director
    Hayne Old Manor
    Moreton Hampstead
    TQ13 8SB Newton Abbot
    Devon
    British35908860001
    DARBY, Neil Sidney
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    United Kingdom
    Director
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish64235430002
    EVANS, Louise Margaret
    Trafalgar Square
    WC2N 5HR London
    One Strand
    United Kingdom
    Director
    Trafalgar Square
    WC2N 5HR London
    One Strand
    United Kingdom
    United KingdomBritish164439180002
    GOWER, Kenneth Stanley
    11 Round Ash Way
    Hartley
    DA3 8BT Longfield
    Kent
    Director
    11 Round Ash Way
    Hartley
    DA3 8BT Longfield
    Kent
    British30104950001
    GREEN, Michael Robert
    Cory House
    21 Berth Tilbury Docks
    RM18 7JT Tilbury
    Essex
    Director
    Cory House
    21 Berth Tilbury Docks
    RM18 7JT Tilbury
    Essex
    United KingdomBritish50520570001
    HARMAN, Tracy Ann
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    United Kingdom
    Director
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish195416610001
    HARRISON, Michael James
    3 Caldecote Close
    ME8 8TP Rainham
    Kent
    Director
    3 Caldecote Close
    ME8 8TP Rainham
    Kent
    EnglandBritish54184950001
    OVERSTALL, Charles Andrew
    Carkin
    East Layton
    DL11 7PE Richmond
    North Yorkshire
    Director
    Carkin
    East Layton
    DL11 7PE Richmond
    North Yorkshire
    British53604540001
    RAINE, Christopher
    6 Eastfield Road, Noak Bridge
    Laindon
    SS15 4JE Basildon
    Essex
    Director
    6 Eastfield Road, Noak Bridge
    Laindon
    SS15 4JE Basildon
    Essex
    British21089060005
    RAISTRICK, George
    12 Weston Avenue
    Fellside Park
    NE16 5TS Whickham
    Newcastle Upon Tyne
    Director
    12 Weston Avenue
    Fellside Park
    NE16 5TS Whickham
    Newcastle Upon Tyne
    British9839400001
    ROBINSON, Frank William
    33 Sebastian Avenue
    Shenfield
    CM15 8PW Brentwood
    Essex
    Director
    33 Sebastian Avenue
    Shenfield
    CM15 8PW Brentwood
    Essex
    British2664580001
    RUSSELL, James
    21 Fontburn
    Amble
    NE65 0BL Morpeth
    Northumberland
    Director
    21 Fontburn
    Amble
    NE65 0BL Morpeth
    Northumberland
    British39082080001
    TODD, Alan Russell
    Hathaway Grosvenor Road
    GU7 1PA Godalming
    Surrey
    Director
    Hathaway Grosvenor Road
    GU7 1PA Godalming
    Surrey
    British12344090001
    VANE, Alexander Chandos Tempest
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    Director
    Old Clatterbridge Road
    Bebington
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    Merseyside
    EnglandBritish131374740001
    WOOD, Terence
    78 Littleover Lane
    DE23 6JG Derby
    Derbyshire
    Director
    78 Littleover Lane
    DE23 6JG Derby
    Derbyshire
    British13931780001
    YEOMAN, Campbell
    1 The Barkery
    Newby
    TS8 0AW Middlesbrough
    Cleveland
    Director
    1 The Barkery
    Newby
    TS8 0AW Middlesbrough
    Cleveland
    British12303640001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Old Clatterbridge Road
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Old Clatterbridge Road
    CH63 4JB Wirral
    Claremont Buildings
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro415497
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene LONDON CENTRAL CRUISE MOORINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 27 ago 2004
    Entregado el 04 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 16 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0