LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 00427081 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED?
- Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Lonsdale & Marsh 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street L3 9LQ Liverpool England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 oct 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 jul 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 27 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 10 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 27 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2024 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Roy Batterbee como director el 01 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Boat House Carr Mill Dam Garswood Old Road St. Helens Merseyside WA11 7LZ England a C/O Lonsdale & Marsh 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street Liverpool L3 9LQ el 27 jun 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 oct 2023 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 oct 2022 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher James Dakin como director el 12 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 oct 2021 | 4 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Sarah Louise Smith como secretario el 27 jul 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Sarah Louise Smith como director el 27 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 oct 2020 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Malcolm David Hughes como director el 19 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Stuart Michael Bird como director el 19 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Adrian Richard Morse como director el 19 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Christopher James Dakin como director el 19 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Smee como director el 17 may 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Aaron como director el 22 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2019 | 9 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Roy Batterbee como director el 24 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Tim Mooney como director el 08 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 27 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRD, Stuart Michael | Director | 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street L3 9LQ Liverpool C/O Lonsdale & Marsh England | England | British | Communications Manager | 283639140001 | ||||
| GOODMAN, Geoffrey, Pres | Director | 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street L3 9LQ Liverpool C/O Lonsdale & Marsh England | England | British | Draftsman | 12431140002 | ||||
| HUGHES, Malcolm David | Director | 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street L3 9LQ Liverpool C/O Lonsdale & Marsh England | England | English | Manager | 2514210001 | ||||
| MORSE, Adrian Richard | Director | 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street L3 9LQ Liverpool C/O Lonsdale & Marsh England | England | Welsh | Operations Manager | 283639110001 | ||||
| MORSE, Ruth Lillian | Director | 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street L3 9LQ Liverpool C/O Lonsdale & Marsh England | England | British | It Service Manager | 99279320003 | ||||
| OWEN, William Joseph | Director | 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street L3 9LQ Liverpool C/O Lonsdale & Marsh England | England | English | Transport Manager | 16543240001 | ||||
| PALFREYMAN, Matthew James | Director | Garswood Old Road WA11 7LZ St. Helens The Boat House Lancashire England | England | British | Director | 173035020002 | ||||
| BLANE, Stuart Martin | Secretario | 61 Blaguegate Lane Lathom WN8 8TY Skelmersdale Lancashire | British | 104657690001 | ||||||
| PALFREYMAN, Graham | Secretario | Carr Mill Dam Garswood Old Road WA11 7LZ St. Helens The Boat House Merseyside England | British | Loss Adjuster | 111624580002 | |||||
| SCOTT, David William | Secretario | 12 Beech Walk WN7 3LH Leigh Lancashire | British | Drilling Contractor | 7656660001 | |||||
| SCOTT, Paul Alexander | Secretario | 12 Beech Walk WN7 3LH Leigh Lancashire | British | Surveyor | 91074010001 | |||||
| SHAW, Christopher Martin | Secretario | Meadow Croft 95 Mustard Lane Croft WA3 7BD Warrington | British | Sales Manager | 46538390002 | |||||
| SMITH, Sarah Louise | Secretario | Carr Mill Dam Garswood Old Road WA11 7LZ St. Helens The Boat House Merseyside England | 245566930001 | |||||||
| AARON, Paul | Director | Carr Mill Dam Garswood Old Road WA11 7LZ St. Helens The Boat House Merseyside England | United Kingdom | British | Director | 186307840001 | ||||
| BALFOUR, Paul Robert | Director | 38 Skyes Crescent Winstanley WN3 6HU Wigan Lancashire | British | Motor Engineer | 76601320001 | |||||
| BATTARBEE, Roy | Director | Carr Mill Dam Garswood Old Road WA11 7LZ St. Helens The Boat House Merseyside England | United Kingdom | British | Director | 104584500001 | ||||
| BATTERBEE, Roy | Director | 509 - 510 Cotton Exchange Bixteth Street L3 9LQ Liverpool C/O Lonsdale & Marsh England | England | British | Company Director | 272478800001 | ||||
| BLANE, Stuart Martin | Director | 61 Blaguegate Lane Lathom WN8 8TY Skelmersdale Lancashire | British | Works Manager | 104657690001 | |||||
| BREWER, Jason Marcus | Director | Lime Kiln Way LN2 4US Lincoln Millennium House England | England | British | Director | 137261980001 | ||||
| CARD, Stephen Leslie | Director | 39 Park Road Stretford M32 8FE Manchester | British | Warehouse Checker | 43637630001 | |||||
| CASH, Steven Alan | Director | 6 Newcroft Drive Edgeley SK3 9RY Stockport Cheshire | British | Production Manager | 48326460002 | |||||
| COWARD, Harry | Director | 15 Duffins Close OL12 6XA Rochdale Lancashire | British | Retail Food | 53367000001 | |||||
| COWARD, Harry | Director | 15 Duffins Close OL12 6XA Rochdale Lancashire | British | Market Trader | 53367000001 | |||||
| CRADDOCK, Mark | Director | Shefford Crescent WN3 6LF Wigan 3 Lancashire | England | British | Motor Trade | 140256620001 | ||||
| CUNLIFFE, Glynn | Director | New Street Pemberton WN5 8BY Wigan 27 Lancashire | United Kingdom | British | Civil Engineer | 167872770001 | ||||
| DAKIN, Christopher James | Director | Carr Mill Dam Garswood Old Road WA11 7LZ St. Helens The Boat House Merseyside England | England | English | Company Director | 283639080001 | ||||
| DUFF, Michael, Vice President | Director | 14 Wilmcote Grove Ainsdale PR8 2SP Southport Merseyside | British | Dental Technician | 9950590001 | |||||
| EVANS, Douglas | Director | 181 Dukinfield Road SK14 4QD Hyde Cheshire | United Kingdom | British | Computer Systems Sales | 21277700002 | ||||
| FAIRHURST, Russell | Director | 7 Sandpiper Road Highfield WN3 6AX Wigan Lancashire | British | Builder | 43637370001 | |||||
| FITZSIMMONS, Deborah | Director | 13 Poverty Lane Maghull L31 3EX Liverpool | British | Administrator | 82777020001 | |||||
| FITZSIMMONS, Steven | Director | 13 Poverty Lane Maghull L31 3EX Liverpool Merseyside | England | British | Builder | 111626720001 | ||||
| GAMMOND, David Keith | Director | 18 Riverside Chadderton OL1 2TX Oldham Lancashire | England | British | Director | 12342460001 | ||||
| GIBBS, Alan, Immediate Past Commodore | Director | 65 Mapplewell Crescent Gt Sankey WA5 1UU Warrington Cheshire | British | Lubricant Salesman | 9950550001 | |||||
| GOODMAN, Brenda Hazel | Director | Lime Kiln Way LN2 4US Lincoln Millennium House England | United Kingdom | British | Director | 12431130001 | ||||
| GOODMAN, Malcolm | Director | Lime Kiln Way LN2 4US Lincoln Millennium House England | England | British | Pipe Fitter | 134756120002 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LANCASHIRE POWERBOAT RACING CLUB LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 27 may 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0