SDI SPORTS (SC 2016) LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | SDI SPORTS (SC 2016) LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00429750 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SDI SPORTS (SC 2016) LTD?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra SDI SPORTS (SC 2016) LTD?
| Dirección de la sede social | Unit A Brook Park East NG20 8RY Shirebrook |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SDI SPORTS (SC 2016) LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DUNLOP SPORTS COMPANY LIMITED | 17 feb 1947 | 17 feb 1947 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SDI SPORTS (SC 2016) LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SDI SPORTS (SC 2016) LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2020 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Thomas James Piper como secretario el 01 jul 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Cameron John Olsen como secretario el 01 jul 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Alastair Peter Orford Dick el 01 may 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alastair Peter Orford Dick como director el 14 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rachel Isabel Lilian Stockton como director el 14 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cessation de Dunlop Slazenger Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 dic 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Comptes modifiés pour une société dormante établis au 30 abr 2016 | 7 páginas | AAMD | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de David Michael Forsey como director el 14 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Rachel Isabel Lilian Stockton como director el 14 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Wallace Ashley como director el 14 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Adedotun Ademola Adegoke como director el 14 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SDI SPORTS (SC 2016) LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPER, Thomas James | Secretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 260021810001 | |||||||
| ADEGOKE, Adedotun Ademola | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 203129860001 | |||||
| DICK, Alastair Peter Orford | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 256598390002 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Secretario | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MELLORS, Robert Frank | Secretario | The Warrener Warren Row RG10 8QS Reading Berkshire | British | 30104540002 | ||||||
| MOODIE, Gordon Murray | Secretario | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| OLSEN, Cameron John | Secretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 183494020001 | |||||||
| RITCHIE, Alistair John, Sol | Secretario | Waterman's Lodge 15 Beales Lane KT13 8JS Weybridge Surrey | British | 6417760002 | ||||||
| SIMPSON, Brian Charles | Secretario | 15 Langham Way RG10 8AX Wargrave Berkshire | British | 47141350001 | ||||||
| TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise | Secretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | British | 131967270001 | ||||||
| INVENSYS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London | 75491680001 | |||||||
| AINSLEY, Stanley | Director | Ash Tree Cottage Maidensgrove RG9 6EZ Henley On Thames Oxfordshire | British | 59267330001 | ||||||
| ASHLEY, Michael James Wallace | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British | 95500210002 | |||||
| AUSTEN, Patrick George | Director | 14 Chantry View Road GU1 3XR Guildford Surrey | British | 55015730001 | ||||||
| BROWN, Robert Casson | Director | 38 Newlands Avenue Melton Park NE3 5PX Newcastle Upon Tyne | British | 6343100001 | ||||||
| BROWN, Robert Casson | Director | 38 Newlands Avenue Melton Park NE3 5PX Newcastle Upon Tyne | British | 6343100001 | ||||||
| FORSEY, David Michael | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British | 147207580002 | |||||
| JACOBS, David Michael | Director | Riverside House Hall Cottages Lodden Drive RG10 8ND Reading Berkshire | British | 47141160001 | ||||||
| JENKINS, Brian John | Director | 27 Fort Road GU1 3TE Guildford Surrey | England | British | 12010260001 | |||||
| LOVELL, Alan Charles | Director | The Palace House Bishops Lane SO32 1DP Bishops Waltham Hampshire | England | British | 149625410001 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Director | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MARNOCH, Alasdair, Mr. | Director | Bramble Bottom Wedmans Lane RG27 9BX Rotherwick Hampshire | England | British | 216655900001 | |||||
| MELLORS, Robert Frank | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 30104540005 | |||||
| MOODIE, Gordon Murray | Director | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| PARNELL, Philip John | Director | The Old Bell House The Common HP10 8LQ Penn Buckinghamshire | England | British | 57485400001 | |||||
| PETERS, Andrew Robert Gerald, 151298 | Director | 1 Josephine Avenue KT20 7AB Lower Kingswood Surrey | British | 56810170001 | ||||||
| RONNIE, Christopher | Director | 18 Macclesfield Road SK9 2AA Wilmslow Cheshire | British | 79360390001 | ||||||
| STOCKTON, Rachel Isabel Lilian | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 245592990001 | |||||
| THOM, James Demmink | Director | Tollgate Cottage Turners Hill Road RH10 4HG Crawley Down West Sussex | British | 38683120002 | ||||||
| WILLIAMS, Stanley Killa | Director | White Raven Park Lane KT21 1EU Ashtead Surrey | England | British | 34401400001 | |||||
| WILLIAMS, Stanley Killa | Director | White Raven Park Lane KT21 1EU Ashtead Surrey | England | British | 34401400001 | |||||
| WYCHERLEY, Peter | Director | 394 Barnsley Road Sandal WF2 6BW Wakefield West Yorkshire | British | 130910001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SDI SPORTS (SC 2016) LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slazenger Carlton (Holdings) Limited | 16 dic 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Dunlop Slazenger Group Limited | 06 abr 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SDI SPORTS (SC 2016) LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Creado el 04 abr 1996 Entregado el 19 abr 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the financing documents (as defined in the charge) and all monies due or to become due from pixelframe limited (now renamed dunlop slazenger group limited) (newco) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed) under or in connection with the vendor a note (as therein defined) including the guarantee liabilities of the company to pay all monies due to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trade marks and patents charge | Creado el 04 abr 1996 Entregado el 19 abr 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the financing documents (as defined in the charge) and all monies due or to become due from pixelframe limited (now renamed dunlop slazenger group limited) (newco) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed) under or in connection with the vendor a note (as therein defined) including the guarantee liabilities of the company to pay all monies due to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Breve descripción All the trade marks set out in schedule 1 of the deed and form 395 together with all goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 may 1984 Entregado el 06 jun 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees on any account whatsoever | |
Breve descripción All f/h & l/h property with all fixtures thereon undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. For further details see doc M102. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0