GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00442028 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED?
Dirección de la sede social | Accolade House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Surrey |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
HUDSON & HILL LIMITED | 10 sept 1947 | 10 sept 1947 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 19 dic 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Steven Lee Gorst el 01 jun 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Anthony Graham Wood como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert John Ratcliffe como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Sinclair como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mrs Nicola Jane Spencer como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Esther Clothier como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Steven Lee Gorst como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gavin Brockett como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy James Sinclair como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Jeremy Stevenson el 26 feb 2013 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Troy Christensen como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Michael Schaafsma como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Lousada como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPENCER, Nicola Jane | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 180939120001 | |||||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 161853820001 | |||||||
GORST, Steven Lee | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Canada | Canadian | Company Director | 180938750002 | ||||
RATCLIFFE, Robert John | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Management Consultant | 185752460001 | ||||
SCHAAFSMA, Paul Michael | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 105189170004 | ||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Solicitor | 161846280001 | ||||
WOOD, Anthony Graham | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Financial Controller | 185752470001 | ||||
CLOTHIER, Esther | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 162190170001 | |||||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Secretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | Company Secretary/ Director | 28396500005 | |||||
HUGHES, David John | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 157433250002 | |||||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Secretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | British | Solicitor | 69554640002 | |||||
MATHEWS, Benedict John Spurway | Secretario | 39 Lower Teddington Road KT1 4HQ Hampton Wick Flat 3 Surrey | British | Company Secretary | 42217530001 | |||||
MILLS, John Michael | Secretario | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
MITCHLEY, Simon Colin | Secretario | 8 Priory Road IG10 1AF Loughton Essex | British | Company Secretary | 36355940001 | |||||
BROCKETT, Gavin Stuart | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | South African | Accountant | 167554030002 | ||||
CHRISTENSEN, Troy | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | American | Company Director | 130789730003 | ||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Director | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | Company Secretary/ Director | 28396500005 | ||||
CREIGHTON, Thomas Hugh | Director | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | Accountant | 157727790001 | ||||
EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Director | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | England | British | Solicitor/Co Secretary | 49678170001 | ||||
ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | Company Director | 1491130002 | ||||
GLENNIE, Helen Margaret | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 137615160001 | ||||
HODGES, Nigel Ian | Director | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | Business Development Executive | 75692570001 | |||||
HUGHES, David John | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Accountant | 157415150002 | ||||
HUNTLEY, Peter William | Director | 28 Allan Glen Gardens Bishopbriggs G64 3BG Glasgow | Scotland | British | Company Director | 46387640002 | ||||
JOHNSTON, Ian Andrew Hill | Director | 15 Caroline Terrace SW1W 8JT London | British | Director | 1785700001 | |||||
KLEIN, David | Director | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | Company Director | 119928070001 | |||||
LOUSADA, James David | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 152222000001 | ||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 69554640002 | ||||
MILLS, John Michael | Director | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | Chartered Secretary | 42268710001 | |||||
MORGAN, Alistair Mclauchlan | Director | 43 Lauderdale Drive Petersham TW10 7BS Richmond Surrey | British | Finance Director | 1785720001 | |||||
PETERS, Richard David | Director | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 60630980002 | ||||
SINCLAIR, Timothy James | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Chief Hr Officer | 171523300001 | ||||
STEVENS, David John | Director | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | Group Legal Director | 56704240001 | |||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Solicitor | 161846280001 | ||||
TAUTZ, Helen Jane | Director | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | Csec | 37564540001 |
¿Tiene GRIERSON-BLUMENTHAL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 18 oct 2011 Entregado el 25 oct 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0