AUDIX SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAUDIX SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00443219
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AUDIX SYSTEMS LIMITED?

    • fabricación de productos electrónicos de consumo (26400) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra AUDIX SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AUDIX SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TANNOY AUDIX SYSTEMS LTD.25 jun 199925 jun 1999
    AUDIX COMMUNICATIONS LIMITED01 jul 199301 jul 1993
    AUDIX LIMITED15 nov 199115 nov 1991
    TANNOY AUDIX LIMITED01 nov 198901 nov 1989
    AUDIX LIMITED06 oct 194706 oct 1947

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AUDIX SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AUDIX SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 sept 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Mark Ayre como director el 31 ago 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Bowie como director el 31 ago 2017

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Bowie el 30 jun 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Peter Schieser el 30 jun 2017

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mark Richard Ivill como director el 21 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Anton Bernard Alphonsus como secretario el 10 mar 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Anton Bernard Alphonsus como director el 10 mar 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Peter Schieser como director el 21 abr 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 05 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 sept 2015

    Estado de capital el 30 sept 2015

    • Capital: GBP 1,365,742
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 sept 2014

    Estado de capital el 22 sept 2014

    • Capital: GBP 1,365,742
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 sept 2013

    Estado de capital el 25 sept 2013

    • Capital: GBP 1,365,742
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de AUDIX SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AYRE, Mark
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    Director
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    EnglandBritishFinance Director Transformation129877500001
    SCHIESER, Peter
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    Director
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    LuxembourgGermanDirector179601330001
    ALPHONSUS, Anton Bernard
    The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury-On-Thames
    Security House
    Middlesex
    Secretario
    The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury-On-Thames
    Security House
    Middlesex
    British158440870001
    GODFRAY, Terence William
    39 Robin Lane
    GU47 9AU Sandhurst
    Berkshire
    Secretario
    39 Robin Lane
    GU47 9AU Sandhurst
    Berkshire
    British63510007
    GODWARD, Graham Lewin
    2 Moat Lane
    Melbourn
    SG8 6EH Royston
    Hertfordshire
    Secretario
    2 Moat Lane
    Melbourn
    SG8 6EH Royston
    Hertfordshire
    British18266430001
    IVILL, Mark Richard
    22 The Heritage
    Leyland
    PR25 3ZJ Preston
    Lancashire
    Secretario
    22 The Heritage
    Leyland
    PR25 3ZJ Preston
    Lancashire
    BritishAccountant121133400001
    KEMMANN LANE, Peter James
    62 Park Road
    SS0 7PQ Southend On Sea
    Essex
    Secretario
    62 Park Road
    SS0 7PQ Southend On Sea
    Essex
    British105653330002
    OCHILTREE, Kim Lesley
    25 Nesta Road
    IG8 9RG Woodford Green
    Essex
    Secretario
    25 Nesta Road
    IG8 9RG Woodford Green
    Essex
    BritishAccountant80269530001
    RUSSELL, Peter
    19 Greatfield Way
    Rowlands Castle
    PO9 6AG Havant
    Hampshire
    Secretario
    19 Greatfield Way
    Rowlands Castle
    PO9 6AG Havant
    Hampshire
    BritishDirector36199740001
    STEWART, Michael Henley
    Heathlands Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    Heathlands Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    British6788520001
    ALPHONSUS, Anton Bernard
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    Director
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    EnglandBritishAccountant165072080001
    BISSETT-POWELL, David Norman
    Hillcrest Way
    SLN 8DN Gerrards Cross
    Woodmount
    Buckinghamshire
    Director
    Hillcrest Way
    SLN 8DN Gerrards Cross
    Woodmount
    Buckinghamshire
    BritishDirector135428450001
    BOND, Alan Lawrence
    17 North End
    Bassingbourn
    SG8 5NX Royston
    Hertfordshire
    Director
    17 North End
    Bassingbourn
    SG8 5NX Royston
    Hertfordshire
    BritishSales Director34744590001
    BOWES, James Daniel Burnett
    35 Park Lane
    CB8 8AZ Newmarket
    Suffolk
    Director
    35 Park Lane
    CB8 8AZ Newmarket
    Suffolk
    BritishSales Director69410900001
    BOWIE, Andrew
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    Director
    Tyco Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    United KingdomBritishAccountant140054660001
    CONWAY, Anthony
    Kyles House Penn Road
    Knotty Green
    HP2 2TN Beaconsfield
    Bucks
    Director
    Kyles House Penn Road
    Knotty Green
    HP2 2TN Beaconsfield
    Bucks
    BritishChartered Engineer14665920001
    FIDDY, Gordon Edward
    9 Horseshoe Close
    Balsham
    CB1 6EQ Cambridge
    Director
    9 Horseshoe Close
    Balsham
    CB1 6EQ Cambridge
    United KingdomBritishManaging Director34744600002
    GODWARD, Graham Lewin
    2 Moat Lane
    Melbourn
    SG8 6EH Royston
    Hertfordshire
    Director
    2 Moat Lane
    Melbourn
    SG8 6EH Royston
    Hertfordshire
    BritishFinance Director18266430001
    HAMILTON, Nigel Percy
    Mayfield 38 Burkes Road
    HP9 1PB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Mayfield 38 Burkes Road
    HP9 1PB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director1599140001
    HEAD, Gerald Dennis
    Church View St Katharines Green
    Little Bardfield
    CM7 4TZ Thaxted
    Essex
    Director
    Church View St Katharines Green
    Little Bardfield
    CM7 4TZ Thaxted
    Essex
    United KingdomBritishDirector68525470001
    IVILL, Mark Richard
    22 The Heritage
    Leyland
    PR25 3ZJ Preston
    Lancashire
    Director
    22 The Heritage
    Leyland
    PR25 3ZJ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishAccountant121133400001
    KEMMANN LANE, Peter James
    62 Park Road
    SS0 7PQ Southend On Sea
    Essex
    Director
    62 Park Road
    SS0 7PQ Southend On Sea
    Essex
    BritishAccountant105653330002
    MUNRO, Colin Alexander
    34 Danube Street
    EH4 1NT Edinburgh
    Lothian
    Director
    34 Danube Street
    EH4 1NT Edinburgh
    Lothian
    BritishDirector16396840002
    NEALE, David
    Trafalgar Road
    Birkdale
    PR8 2EA Southport
    9
    United Kingdom
    Director
    Trafalgar Road
    Birkdale
    PR8 2EA Southport
    9
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant121132860002
    RAMSEY, Karl David
    54 Woodleigh Avenue
    SS9 4JB Leigh On Sea
    Essex
    Director
    54 Woodleigh Avenue
    SS9 4JB Leigh On Sea
    Essex
    BritishAccountant112089890001
    ROBERTS, Paul Timothy Hall
    The Croft
    Highfield Lane
    SO17 1NQ Southampton
    Hampshire
    Director
    The Croft
    Highfield Lane
    SO17 1NQ Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishDirector14469590001
    RUSSELL, Peter
    19 Greatfield Way
    Rowlands Castle
    PO9 6AG Havant
    Hampshire
    Director
    19 Greatfield Way
    Rowlands Castle
    PO9 6AG Havant
    Hampshire
    BritishDirector36199740001
    STEWART, Michael Henley
    Heathlands Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Heathlands Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector6788520001
    WESTON, Clive Richard
    14 The Mallards
    Chobham Road
    GU16 8PB Frimley
    Surrey
    Director
    14 The Mallards
    Chobham Road
    GU16 8PB Frimley
    Surrey
    BritishEngineer99040810001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AUDIX SYSTEMS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Thorn Security Limited
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury-On-Thames
    Security House, The Summit
    England
    06 abr 2016
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury-On-Thames
    Security House, The Summit
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroUnited Kingdom Companies House
    Número de registro728246
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene AUDIX SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 08 may 1989
    Entregado el 18 may 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 may 1989Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 06 oct 1988
    Entregado el 26 oct 1988
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All moies due or to become due from the company to the chargee and/or charles john billett and john anthony billett on any account whatsoever.
    Breve descripción
    68 bestfield road stansted essex.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 oct 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 06 oct 1988
    Entregado el 26 oct 1988
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or charles john billett and john anthony billett
    Breve descripción
    Land adjoining neville house wendon saffron walden essex.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 oct 1988Registro de una carga
    Guarantee & debenture
    Creado el 01 nov 1985
    Entregado el 07 nov 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or gresham wood industries limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 nov 1985Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0