DERWENT VALLEY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DERWENT VALLEY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00445037 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DERWENT VALLEY LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra DERWENT VALLEY LIMITED?
Dirección de la sede social | 25 Savile Row London W1S 2ER |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DERWENT VALLEY LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BRITISH COMMERCIAL PROPERTY INVESTMENT TRUST LIMITED | 13 nov 1947 | 13 nov 1947 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DERWENT VALLEY LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DERWENT VALLEY LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 16 abr 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 30 abr 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 16 abr 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DERWENT VALLEY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nigel Quentin George el 30 ene 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Gary Silverman como director el 14 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 32 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de Lms Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 jun 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Emily Joanna Prideaux como director el 01 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Paul Silver como director el 26 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John David Burns como director el 17 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Malcolm Williams el 09 jul 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DERWENT VALLEY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAWLER, David Andrew | Secretario | 25 Savile Row London W1S 2ER | 238973290001 | |||||||
GEORGE, Nigel Quentin | Director | 25 Savile Row London W1S 2ER | United Kingdom | British | Director | 26640150007 | ||||
PRIDEAUX, Emily Joanna | Director | 25 Savile Row London W1S 2ER | England | British | Director | 265814770001 | ||||
WILLIAMS, Paul Malcolm | Director | 25 Savile Row London W1S 2ER | United Kingdom | British | Surveyor | 10072820003 | ||||
WISNIEWSKI, Damian Mark Alan | Director | Savile Row W1S 2ER London 25 | England | British | Director | 148838200001 | ||||
KITE, Timothy James | Secretario | Arisaig Reading Road North GU51 4HP Fleet Hampshire | British | 107553690001 | ||||||
MITCHLEY, Simon Colin | Secretario | 34 Harris Lane Shenley WD7 9EG Radlett Hertfordshire | British | 53655170004 | ||||||
WALDRON, Michael | Secretario | 14 Wimpole Mews W1G 8PE London | British | 8811160003 | ||||||
BURNS, John David | Director | 25 Savile Row London W1S 2ER | United Kingdom | British | Director | 9820610002 | ||||
DRIVER, Nicholas Gordon Ellis | Director | Pullens Cottage 2 Leigh Hill Road KT11 2HX Cobham Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 8811170002 | ||||
FRIEDLOS, Nicholas Robert | Director | 13 Alwyne Road N1 2HH London | England | British | Finance Director | 61183260002 | ||||
GROVES, Nicholas Thomas Julian | Director | 37 Vicarage Road East Sheen SW14 8PZ London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 157469310001 | ||||
MILLER, Eric Gordon | Director | Juxta Mill Duck End Finchingfield CM7 4NA Braintree Essex | British | Building Surveyor | 16097160002 | |||||
MILLSOM, Walter | Director | 3 Tollgate Drive College Road Dulwich SE21 7LS London | England | British | Chartered Surveyor | 16095080001 | ||||
NEWMAN, Malcolm | Director | 1 Green Avenue Mill Hill NW7 4PX London | British | Chartered Surveyor | 16097170001 | |||||
ODOM, Christopher James | Director | 19 Embercourt Road KT7 0LH Thames Ditton Surrey | British | Chartered Accountant | 20951000001 | |||||
PEXTON, Martin Andrew | Director | Little Kensham Farm, Sandhurst Lane Rolvenden TN17 4PH Cranbrook Kent | England | British | Director | 87643530001 | ||||
RAYNE, Max, Lord | Director | 33 Robert Adam Street W1U 3HR London | British | Director | 35619240001 | |||||
RAYNE, Robert Anthony, The Honourable | Director | 37 Brunswick Gardens W8 4AW London | England | British | Director | 53009350001 | ||||
SILVER, Simon Paul | Director | 25 Savile Row London W1S 2ER | United Kingdom | British | Director | 35534690001 | ||||
SILVERMAN, David Gary | Director | 25 Savile Row London W1S 2ER | United Kingdom | British | Director | 126851570001 | ||||
SPIER, Robert Fitzhardinge Jenner | Director | The Barn High Street North Stewkley LU7 0EZ Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Chartered Accountant | 8842440001 | |||||
WALDRON, Michael | Director | 14 Wimpole Mews W1G 8PE London | British | Co Sec | 8811160003 | |||||
WOOD, Richard John | Director | 7 Maple Road KT21 2LX Ashtead Surrey | British | Chartered Surveyor | 63468850001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DERWENT VALLEY LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lms Finance Limited | 06 abr 2016 | Savile Row W1S 2ER London 25 London England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene DERWENT VALLEY LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Second supplemental trust deed | Creado el 22 nov 2002 Entregado el 28 nov 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the issuer or any substitute principal debtor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First floating charge over all undertaking,property and assets whatsoever including any uncalled capital; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Third supplemental trust deed | Creado el 20 ene 1992 Entregado el 21 ene 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The principal of and interest on the £100,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of london merchant securities PLC and all other moneys due or to become due to the law debenture trust corporation P.L.C. (the "trustee") under the third supplemental trust deed and the trust deed dated 22ND march 1988 and the deeds supplemental thereto dated 16TH november 1989 and 30TH september 1991 to which the said third supplemental trust deed is supplemental (including £60,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of london merchant securities PLC already issued) | |
Breve descripción Harp house,83/86 farringdon street,and 12 harp alley,london,EC4 all moneys to be received by virtue of any insurances (see doc ref M91 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of covenant | Creado el 22 ene 1964 Entregado el 12 feb 1964 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £35,192 now due etc & outstanding under a charge created by rayne investments LTD dated 9/6/55 | |
Breve descripción 72 wigmore street & 13 marylebone lane london W.1 (see doc 39). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 11 ago 1954 Entregado el 13 ago 1954 | Pendiente | Cantidad garantizada £50,000 | |
Breve descripción 103 mount street london W1. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge by way of collateral security | Creado el 08 may 1951 Entregado el 15 may 1951 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing £135,000 by charge d/d 5/12/49 | |
Breve descripción No 27 maddox st. London W1. And capital redemption policy. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge & mortgage | Creado el 05 dic 1949 Entregado el 07 dic 1949 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sums not exceeding £135,000. | |
Breve descripción F/H/land and buildings formerly k/a 83,84,85,& 86 farringdon street london L.R. t/n 233516 f/h land & bldgs formerly known as 12 harp alley farringdon street north london L.R. t/n 160646 l/h 103 mount street westminster london. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0