ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED

ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00453907
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED?

    • (5156) /

    ¿Dónde se encuentra ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ROBERT HORNE & COMPANY (EXPORT) LIMITED10 may 194810 may 1948

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Huntsman House Mansion Close Moulton Park Northampton NN3 6LA el 11 jul 2011

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 jun 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 05 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 mar 2011

    Estado de capital el 18 mar 2011

    • Capital: GBP 3,000
    SH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2010

    5 páginasAA

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2009

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de David Stuart Allen como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alistair Gough como director

    1 páginasTM01

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2008

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2007

    5 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2006

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SIGLEY, Caroline
    2 Stone Cottages
    Newlands
    NN6 9DN Brixworth
    Ivydene
    Northamptonshire
    Secretario
    2 Stone Cottages
    Newlands
    NN6 9DN Brixworth
    Ivydene
    Northamptonshire
    Other66259630002
    ALLEN, David Stuart
    Spring Coppice Drive
    Dorridge
    B93 8JX Solihull
    5
    West Midlands
    Director
    Spring Coppice Drive
    Dorridge
    B93 8JX Solihull
    5
    West Midlands
    EnglandBritish108844420002
    ARMSTON, Mark
    The Green
    Crowell
    OX39 4RR Chinnor
    Hill Cottage
    Oxfordshire
    Director
    The Green
    Crowell
    OX39 4RR Chinnor
    Hill Cottage
    Oxfordshire
    EnglandBritish136160320001
    JONES, Robin Jeffrey Llewellyn
    14 Willow Close
    Spratton
    NN6 8JH Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    14 Willow Close
    Spratton
    NN6 8JH Northampton
    Northamptonshire
    British56115480001
    ALLEN, David Stuart
    5 Spring Coppice Drive
    Dorridge
    B93 8JX Solihull
    West Midlands
    Director
    5 Spring Coppice Drive
    Dorridge
    B93 8JX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish108844420002
    BAIRSTOW, Michael Trevor
    Manor House 37 Main Street
    Great Oxendon
    LE16 8NE Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    Manor House 37 Main Street
    Great Oxendon
    LE16 8NE Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish35517700001
    BALKHAM, Terrence William
    15 Devonshire Park
    RG2 7DX Reading
    Berkshire
    Director
    15 Devonshire Park
    RG2 7DX Reading
    Berkshire
    British60255770002
    GOUGH, Alistair Storrar
    The Red Gables
    19 Mears Ashby Road
    NN6 0HQ Earls Barton
    Northamptonshire
    Director
    The Red Gables
    19 Mears Ashby Road
    NN6 0HQ Earls Barton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish151152210001
    HEATH, Bryan Patrick Alan
    5 Devonshire Close
    Boughton
    NN2 8RY Northampton
    Northamptonshire
    Director
    5 Devonshire Close
    Boughton
    NN2 8RY Northampton
    Northamptonshire
    British26000120001
    JONES, Robin Jeffrey Llewellyn
    14 Willow Close
    Spratton
    NN6 8JH Northampton
    Northamptonshire
    Director
    14 Willow Close
    Spratton
    NN6 8JH Northampton
    Northamptonshire
    British56115480001
    MARCHANT, Toby Richard
    Granborough Lodge
    Granborough
    MK18 3NP Buckingham
    Director
    Granborough Lodge
    Granborough
    MK18 3NP Buckingham
    EnglandBritish110648600001
    MARTIN, Jeremy Nicholas
    Orchard House
    Hartwell Road
    NN7 2JR Ashton
    Northamptonshire
    Director
    Orchard House
    Hartwell Road
    NN7 2JR Ashton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish89645830001
    MASON, John Stephen
    Acorn Cottage
    Preston Deanery
    NN7 2DU Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Acorn Cottage
    Preston Deanery
    NN7 2DU Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish6821560001
    MORGAN, Dennis
    9 Leaconfield Drive
    Worsley
    M28 2WE Manchester
    Lancashire
    Director
    9 Leaconfield Drive
    Worsley
    M28 2WE Manchester
    Lancashire
    British63504420002
    MORGAN, Dennis
    41 Radcliffe Park Road
    M6 7WP Salford
    Manchester
    Director
    41 Radcliffe Park Road
    M6 7WP Salford
    Manchester
    British63504420001
    SUMMERSIDE, John
    Cotswold House 23 Westhorpe
    Sibbertoft
    LE16 9UL Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    Cotswold House 23 Westhorpe
    Sibbertoft
    LE16 9UL Market Harborough
    Leicestershire
    British6821600001

    ¿Tiene ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 oct 1999
    Entregado el 15 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent under the debenture and the lenders party from time to time to the credit agreement (as defined) under the credit agreement and the subsidiaries guaranty dated 26TH october 1999
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bankers Trust Company
    Transacciones
    • 15 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ADHESIVE AND DISPLAY PRODUCTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 jul 2012Fecha de disolución
    30 jun 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Kerry Lynne Trigg
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0