ENODIS INVESTMENTS LIMITED

ENODIS INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENODIS INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00455541
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BERISFORD INVESTMENTS LIMITED05 dic 199605 dic 1996
    BERISFORD PROPERTY INVESTMENTS LIMITED26 sept 199126 sept 1991
    BERISFORD (CREDIT RESOURCES) LIMITED11 jun 198711 jun 1987
    J.H. RAYNER (HOLDINGS) LIMITED25 mar 198325 mar 1983
    ZWANENBERG ASSOCIATED FOOD COMPANIES LIMITED15 jun 194815 jun 1948

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2020

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    36 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2019

    13 páginasAA

    legacy

    28 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Esyllt John-Featherby como director el 19 jun 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Albert James Rourke como director el 19 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cessation de Enodis Property Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 feb 2020

    1 páginasPSC07

    Modification des détails de Enodis Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 feb 2020

    2 páginasPSC05

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 27 feb 2020

    • Capital: GBP 0.50
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    6 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018

    12 páginasAA

    legacy

    32 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    ¿Quiénes son los directivos de ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Secretario corporativo
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Director
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JOHN-FEATHERBY, Esyllt
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    Director
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    EnglandBritish273323780001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Secretario
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Director
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BOWKETT, Alan John
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    Director
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish33301630002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Director
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Director
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Director
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Director
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Director
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Director
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Director
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    LEE, Paul Allan
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    Director
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    EnglandBritish70564410001
    MITCHELL, Graham Ramsay
    53 Goodhart Place
    E14 8EQ London
    Director
    53 Goodhart Place
    E14 8EQ London
    EnglandBritish105501360001
    NOBLE, Andrew Villiers
    386 Malden Road
    KT4 7NJ Worcester Park
    Surrey
    Director
    386 Malden Road
    KT4 7NJ Worcester Park
    Surrey
    British64593020001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Director designado
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    ROURKE, John Albert James
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    Director
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United KingdomBritish77646900002
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Director
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    WINTON, Adam Howard
    23 Armitage Road
    Golders Green
    NW11 8QT London
    Director
    23 Armitage Road
    Golders Green
    NW11 8QT London
    EnglandBritish50077250001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director corporativo
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director corporativo
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    06 abr 2016
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2629464
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Enodis Group Limited
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    06 abr 2016
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroCompanies House
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroEngland
    Número de registro4330202
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ENODIS INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creado el 11 abr 2002
    Entregado el 25 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 25 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creado el 20 feb 2002
    Entregado el 08 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 08 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creado el 22 nov 2001
    Entregado el 30 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 16 sept 1993
    Entregado el 20 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each of the indebtedness agreements (as defined)
    Breve descripción
    The f/h property k/a bredbury industrial park stockport t/n gm 625224. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of amendment
    Creado el 01 nov 1991
    Entregado el 15 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee (the security agent) and the banks or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements and under the terms of the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 oct 1991
    Entregado el 14 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the chargee (the second security agent) and the banks (as defined therein) or any of them under the terms of the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from the company under the subordinated guarantee and under the terms of the charge
    Breve descripción
    All that f/h land and buildings south side of bulsbrook road, hayes t/no. ALCH3721 - see form 395 for further details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 1991Registro de una carga
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 oct 1991
    Entregado el 14 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due form each obligor (as defined therein) to the chargee (the security agent) and the banks (as defined therein) or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements and under the terms of the charge
    Breve descripción
    All f/h land and buildings south side of bulsbrook road, hayes t/no. ALCH3721 and all f/h land k/a 3 and 4 the square, petersfield, hampshire - see form 395 for further details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 1991Registro de una carga
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 30 jul 1991
    Adquirido el 31 ene 1992
    Entregado el 11 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the refinancing agreement dated 21/09/90
    Breve descripción
    Units 51, 52, 53, 54, 56 and 57 the maltings, bath street, gravesend, kent title numbers: K709759; K709757; K709758; K709762; K709761; and K709760 land previously k/a the depot, 44 and 45 west street, gravesend, gravesham, kenttitle number: K608279.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 feb 1992Registro de una adquisición (400)
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 30 jul 1991
    Adquirido el 31 ene 1992
    Entregado el 11 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the refinancing agreement dated 21/09/90
    Breve descripción
    Units 51, 52, 53, 54, 56, and 57 the maltings, bath street, gravesend, kent title numbers: K709759; K709757; K709758; K709762; K709761; and K709760 land previously k/a the depot, 44 and 45 west street, gravesend, gravesham, kent title number: K608279.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 feb 1992Registro de una adquisición (400)
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 sept 1990
    Entregado el 09 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the second security agent) and the banks (as therein defined) or any of them under the terms of the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berksford international PLC under the subordinated guarantee
    Breve descripción
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 oct 1990Registro de una carga
    • 30 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 sept 1990
    Entregado el 09 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (as therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements
    Breve descripción
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 oct 1990Registro de una carga
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 09 feb 1990
    Adquirido el 30 sept 1991
    Entregado el 21 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies
    Breve descripción
    13 lower bristol road, avon bath title no av 190171.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 1991Registro de una carga
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 15 jul 1988
    Adquirido el 30 sept 1991
    Entregado el 21 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies
    Breve descripción
    Land on the north & south side of lower bristol road bath, avon title no av 92613.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 1991Registro de una carga
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0