SECURE CONTROLS (UK) LIMITED

SECURE CONTROLS (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSECURE CONTROLS (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00457553
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SECURE CONTROLS (UK) LIMITED?

    • fabricación de otros equipos eléctricos (27900) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra SECURE CONTROLS (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Secure House Lulworth Close
    Chandler's Ford
    SO53 3TL Eastleigh
    Hampshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SECURE CONTROLS (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HORSTMANN GROUP LIMITED19 oct 198719 oct 1987
    HORSTMANN GEAR GROUP LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    HORSTMANN GEAR COMPANY LIMITED (THE)30 jul 194830 jul 1948

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SECURE CONTROLS (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SECURE CONTROLS (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Modification des détails de Sanjaya Singhal en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 jun 2019

    2 páginasPSC04

    Domicilio social registrado cambiado de Secure House Moorside Road Winchester Hampshire SO23 7RX a Secure House Lulworth Close Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TL el 21 jun 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    29 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Suket Singhal como director el 01 abr 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kaushik Ghosh como director el 16 jul 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ananya Singhal como director el 01 abr 2018

    2 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Estado de capital el 28 dic 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    28 páginasAA

    Cancelación total de la carga 12

    6 páginasMR04

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Hillbrow House Hillbrow Road Esher Surrey KT10 9NW United Kingdom a Dixcart House Addlestone Road Bourne Business Park Addlestone Surrey KT15 2LE

    1 páginasAD02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    29 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 22 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 dic 2015

    Estado de capital el 03 dic 2015

    • Capital: GBP 13,099,129
    • Capital: USD 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    20 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SECURE CONTROLS (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PATEL, Kaushak
    Lulworth Close
    Chandler's Ford
    SO53 3TL Eastleigh
    Secure House
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Lulworth Close
    Chandler's Ford
    SO53 3TL Eastleigh
    Secure House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Development127243210002
    SINGHAL, Ananya
    Lulworth Close
    Chandler's Ford
    SO53 3TL Eastleigh
    Secure House
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Lulworth Close
    Chandler's Ford
    SO53 3TL Eastleigh
    Secure House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomIndianDirector247992930001
    EBERHARDT, Martin
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    Secretario
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    BritishCompany Director54644630001
    PANDWAL, Hemender
    Moorside Road
    S0237RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    Secretario
    Moorside Road
    S0237RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    156752770001
    PATIENCE, David William John
    White Oaks
    The Barrows
    BS27 3BG Cheddar
    Somerset
    Secretario
    White Oaks
    The Barrows
    BS27 3BG Cheddar
    Somerset
    British77146160001
    PETERS, Michael Steward
    Orchard House Banbury Lane
    Fosters Booth
    NN12 8LG Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    Orchard House Banbury Lane
    Fosters Booth
    NN12 8LG Towcester
    Northamptonshire
    EnglishDirector51205850001
    ROBERTS, Caroline
    20 Portland Court
    Cumberland Close
    BS1 6XB Bristol
    Secretario
    20 Portland Court
    Cumberland Close
    BS1 6XB Bristol
    BritishAccountant106330190002
    TANNER, Brian Charles
    The Gate House
    Corston
    BA2 9AN Bath
    Avon
    Secretario
    The Gate House
    Corston
    BA2 9AN Bath
    Avon
    British3185630001
    WILCOX, Claire
    11 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RQ Bristol
    Avon
    Secretario
    11 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RQ Bristol
    Avon
    British126753460001
    YATES, Karen Frances
    Skurrayfield House
    34 Wingfield Roaad
    BA14 9ED Trowbridge
    Wiltshire
    Secretario
    Skurrayfield House
    34 Wingfield Roaad
    BA14 9ED Trowbridge
    Wiltshire
    BritishFinance Director47182460002
    AGRAWAL, Vineet
    E-Class Pratap Nagar Industrial Area
    313001 Udaipur
    Secure Meters Limited
    Rajasthan
    India
    Director
    E-Class Pratap Nagar Industrial Area
    313001 Udaipur
    Secure Meters Limited
    Rajasthan
    India
    IndiaIndianDirector158654500001
    BHATT, Kamlesh
    C B - 10b Dda Flats
    FOREIGN Munirka
    New Delhi - 110067
    India
    Director
    C B - 10b Dda Flats
    FOREIGN Munirka
    New Delhi - 110067
    India
    IndiaIndianVp Of Operations126816110001
    CHADBOURNE, Colin
    The Mill Mill Street
    Packington
    LE65 1WL Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Director
    The Mill Mill Street
    Packington
    LE65 1WL Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishDirector41101820002
    DEEMING, David Andrew
    Stanley Bridge House
    Bencroft Hill Stanley
    SN15 3RQ Chippenham
    Wiltshire
    Director
    Stanley Bridge House
    Bencroft Hill Stanley
    SN15 3RQ Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritishEngineering Dir106330330001
    EBERHARDT, Martin
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    Director
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director54644630001
    FARMER, David
    Hill House Harmers Hill
    Newick
    BN8 4LJ Lewes
    East Sussex
    Director
    Hill House Harmers Hill
    Newick
    BN8 4LJ Lewes
    East Sussex
    BritishDirector35569010001
    GHOSH, Kaushik
    Moorside Road
    SO23 7RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    Director
    Moorside Road
    SO23 7RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    EnglandIndianDirector138818080004
    GHOSH, Kaushik
    Oakfields
    Allbrook
    SO504RP Eastleigh
    10
    Hampshire
    England
    Director
    Oakfields
    Allbrook
    SO504RP Eastleigh
    10
    Hampshire
    England
    EnglandIndianManaging Director138818080002
    GOLE, Hemant Chintaman
    E-Class Pratap Nagar Industrial Area
    313001 Udaipur
    Secure Meters Limited
    Rajasthan
    India
    Director
    E-Class Pratap Nagar Industrial Area
    313001 Udaipur
    Secure Meters Limited
    Rajasthan
    India
    IndiaIndianDirector158654350001
    HORSTMANN, William Roger
    Armadale Hayesfield Park
    BA2 4QE Bath
    Avon
    Director
    Armadale Hayesfield Park
    BA2 4QE Bath
    Avon
    BritishDirector25583820001
    JONES, John Stephen Major
    The Elms House
    Twyford
    SO21 1FQ Winchester
    Hants
    Director
    The Elms House
    Twyford
    SO21 1FQ Winchester
    Hants
    BritishDirector35554090001
    LOYNES, Alan
    25 Molivers Lane
    Bromham
    MK43 8JT Bedford
    Bedfordshire
    Director
    25 Molivers Lane
    Bromham
    MK43 8JT Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director7815680001
    MARSON, George Barrie
    Warwick House Bridge Street
    Wickham
    PO17 5JJ Fareham
    Hampshire
    Director
    Warwick House Bridge Street
    Wickham
    PO17 5JJ Fareham
    Hampshire
    BritishDirector15020480001
    MCDOWALL, John Kenneth
    54 Sandown Lodge
    Avenue Road
    KT18 7QU Epsom
    Surrey
    Director
    54 Sandown Lodge
    Avenue Road
    KT18 7QU Epsom
    Surrey
    BritishDirector16163840003
    ORROCK, Ian Jackson
    The Yardhouse
    Edinample
    FK19 8QE Loch Earn
    Perthshire
    Director
    The Yardhouse
    Edinample
    FK19 8QE Loch Earn
    Perthshire
    United KingdomBritishDirector34054760010
    PANDWAL, Hemender
    E-Class Pratap Nagar Industrial Area
    313001 Udaipur
    Secure Meters Limited
    Rajasthan
    India
    Director
    E-Class Pratap Nagar Industrial Area
    313001 Udaipur
    Secure Meters Limited
    Rajasthan
    India
    IndiaIndianDirector105105510001
    PATIENCE, David William John
    White Oaks
    The Barrows
    BS27 3BG Cheddar
    Somerset
    Director
    White Oaks
    The Barrows
    BS27 3BG Cheddar
    Somerset
    UkBritishAccountant77146160001
    SEWELL, Dennis John
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    Director
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    CanadianFinance Director3035310003
    SINGHAL, Sanjaya
    Shubhangan
    Goatacre Road
    GU34 5PU Medstead
    Hampshire
    Director
    Shubhangan
    Goatacre Road
    GU34 5PU Medstead
    Hampshire
    IndiaIndianDirector51868310006
    SINGHAL, Suket
    Moorside Road
    SO23 7RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    Director
    Moorside Road
    SO23 7RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    EnglandIndianManaging Director187441250001
    ST CLAIR, Richard John
    Millstone
    40 Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    Surrey
    Director
    Millstone
    40 Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector53455290005
    STATHAM, James Edward Anthony
    Highlands
    TR11 5LA Helford Passage
    Cornwall
    Director
    Highlands
    TR11 5LA Helford Passage
    Cornwall
    United KingdomBritishCompany Director150614890001
    TANNER, Brian Charles
    The Gate House
    Corston
    BA2 9AN Bath
    Avon
    Director
    The Gate House
    Corston
    BA2 9AN Bath
    Avon
    BritishDirector3185630001
    WHITEHEAD, Colin Bernard
    89 Old Fort Road
    Shoreham Beach
    BN43 5HA Shoreham By Sea
    West Sussex
    Director
    89 Old Fort Road
    Shoreham Beach
    BN43 5HA Shoreham By Sea
    West Sussex
    BritishCompany Director20196890007
    WINDSOR, William Michael
    Lilac Tree House Meopham Green
    Meopham
    DA13 0QU Gravesend
    Kent
    Director
    Lilac Tree House Meopham Green
    Meopham
    DA13 0QU Gravesend
    Kent
    BritishDirector3185640001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SECURE CONTROLS (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Sanjaya Singhal
    Lulworth Close
    Chandler's Ford
    SO53 3TL Eastleigh
    Secure House
    Hampshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Lulworth Close
    Chandler's Ford
    SO53 3TL Eastleigh
    Secure House
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Nacionalidad: Indian
    País de residencia: India
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene SECURE CONTROLS (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 18 may 2011
    Entregado el 19 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • State Bank of India, London Branch
    Transacciones
    • 19 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 19 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Creado el 04 mar 2008
    Entregado el 10 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transacciones
    • 10 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 24 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creado el 04 mar 2008
    Entregado el 10 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transacciones
    • 10 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 24 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 ene 2008
    Entregado el 01 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 01 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 24 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 jul 2001
    Entregado el 08 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under all or any of the financing documents (as defined) or any other documents
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 08 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A supplemental deed created 18 december 1998,except for the equitable charge over real property
    Creado el 30 dic 1998
    Entregado el 31 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies,obligations and liabilities from time to time owing or incurred under or pursuant to the following documents (together,and each as it may be from time to time amended,varied,novated,supplemented or replaced,the "secured documents"),namely:(i) a facility agreement dated 18 february 1998 and made between the parent (as defined) and others as borrowers (as defined) certain banks and financial institutions (as defined) and the security trustee (as defined) (in its capacity as agent and security trustee) pursuant to which facilities in an aggregate principal sum of up to £29,500,000 were made available to the borrowers.(ii) any ancillary facility letters.(iii) any documents entered into pursuant to the facilities agreement.(iv) the counter-indemnity and deposit deed dated 18 february 1998.(v) the inter-creditor agreement dated 18 february 1998.(vi) the debenture.(vii) the deed
    Breve descripción
    The deed charges all of the present and future assets of the company.fixed charges over all of the present and future assets of the company of land,interests in land and fixtures.plant,machinery and equipment.stocks,shares,bonds and other securities of any kind.debts and claims.floating charge over all other present and future assets of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Investment Bank PLC on Behalf of Itself and the Banks and Financial Institutions from Timeto Time Parties to the Secured Documents
    Transacciones
    • 31 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 oct 1986
    Entregado el 06 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fleets house, fleets lane, poole, dorset title no: dt 90414 dt 90018, dt 102710, and dt 112792.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 nov 1986Registro de una carga
    • 17 mar 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 jul 1986
    Entregado el 01 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 ago 1986Registro de una carga
    • 15 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 13 jun 1986
    Entregado el 17 jun 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,600,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H industrial and office premises k/a fleets house, fleets lane, poole, dorset title nos: dt 90414, dt 90018, dt 102710. f/h land at the rear of fleets house, title no:- dt 12792.
    Personas con derecho
    • Norwich General Trust Limited.
    Transacciones
    • 17 jun 1986Registro de una carga
    • 27 feb 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 dic 1979
    Entregado el 08 ene 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Larchwood, 59 newbridge hill bath avon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ene 1980Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 31 dic 1979
    Entregado el 08 ene 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The shack, 61, newbridge hill bath avon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ene 1980Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 01 ago 1974
    Entregado el 06 ago 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Brassmill works, brassmill lane, bath.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 1974Registro de una carga
    • 17 mar 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0