BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00464095 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED?
- Agricultura mixta (01500) / Agricultura, silvicultura y pesca
¿Dónde se encuentra BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED?
Dirección de la sede social | 15th Floor 140 London Wall EC2Y 5DN London United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
B.F.P. HOLDINGS LIMITED | 29 mar 1996 | 29 mar 1996 |
BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED | 29 ene 1949 | 29 ene 1949 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Dakin como director el 08 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Henry Edwards como director el 08 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Russell Charles Gurnhill como director el 08 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Graeme Richard William Hunter como director el 08 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de James Leslie Stone como director el 08 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 jul 2021 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 40 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2021 au 31 jul 2021 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 28 jun 2021
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 004640950011 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURNS, Aaron Jon | Secretario | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | 201648600001 | |||||||||||
HACKENBROCH, Michael Akiva | Director | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 137615220001 | ||||||||
BRADY, James Michael | Secretario | 1 Cromwell Close AL4 9YE St Albans Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 3769730001 | |||||||||
DRAYTON, Robin Michael | Secretario | Stonecross Farm Whepstead IP29 4ST Bury St Edmunds Suffolk | British | 10066820001 | ||||||||||
TOWLER, Roy Sydney | Secretario | 3 Home Farm Blakeney Road Letheringsett NR25 7JL Holt Norfolk | British | Farm Director | 17091930001 | |||||||||
JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | St Thomas Street BS1 6JS Bristol 21 United Kingdom |
| 97584300001 | ||||||||||
BRADY, James Michael | Director | 1 Cromwell Close AL4 9YE St Albans Hertfordshire | England | British | Accountant | 3769730001 | ||||||||
BROWN, Colin Brelsford | Director | 1 Newcombe Drive Feltwell IP26 4AH Thetford Norfolk | United Kingdom | British | Farm Manager | 17449170004 | ||||||||
CLERY, Peter Agar | Director | Curlew Court Guys Head Road Sutton Bridge PE12 9QQ Spalding Lincolnshire | British | Director | 10066810001 | |||||||||
DAKIN, Adam | Director | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | England | English | Company Director | 43193110002 | ||||||||
DRAYTON, Robin Michael | Director | Stonecross Farm Whepstead IP29 4ST Bury St Edmunds Suffolk | British | Director | 10066820001 | |||||||||
EDWARDS, Graham Henry | Director | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | England | British | Chief Executive | 78751620003 | ||||||||
GRIMSDELL, Kenneth Charles | Director | 7 North Street Castle Acre PE32 2BA Kings Lynn Norfolk | British | Farm Manager | 17449180001 | |||||||||
GURNHILL, Russell Charles | Director | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 18192910004 | ||||||||
HODSON, Christopher Mark | Director | Lower Grosvenor Place 4th Floor SW1W 0EN London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Senior Development Finance Manager | 118447210002 | ||||||||
HUNTER, Graeme Richard William | Director | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | England | British | Director | 202994410001 | ||||||||
JENKINS, Duncan Robert | Director | 36 Prickwillow Road CB7 4QT Ely Cambridgeshire | United Kingdom | British | Chartered Town Planner | 121918380001 | ||||||||
KERSHAW, Michael John | Director | Glenridding Wicken Bonhunt CB11 3UG Saffron Walden Essex | British | Insurance Executive | 9454450001 | |||||||||
MILLER, John Graham Rex | Director | 10 Houghton Gardens CB7 4JN Ely Cambridgeshire | British | Accountant | 41263110001 | |||||||||
MORIARTY, Kevin Patrick Joseph | Director | Lower Grosvenor Place 4th Floor SW1W 0EN London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Real Estate Advisor | 147706600001 | ||||||||
PERSKY, Warren Ashley | Director | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 108635640073 | ||||||||
PILKINGTON, Richard Michael | Director | 1 Buckingham Place London SW1E 6HR | United Kingdom | British | Chartered Surveyors | 88322980002 | ||||||||
REID, Allan Martin Russell | Director | 38 Christchurch Road SO23 9SU Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 48907760001 | ||||||||
REISS, Nicholas Gladden | Director | Whipple Green Burdock Lane Great Melton NR9 3BW Norwich | British | Chartered Surveyor | 30200120001 | |||||||||
RICHARDS, Henry Lloyd | Director | 53 Kyrle Road SW11 6BB London | Uk | British | Executive Chairman | 38438730003 | ||||||||
SADLER-BRIDGE, David | Director | Palgrave Hall Sporle PE32 2EN Kings Lynn Norfolk | British | Farm Director | 43566570001 | |||||||||
SIDWELL, John | Director | 35 Holmead Road SW6 2JD London | British | Chartered Accountant | 104665760001 | |||||||||
STEPHENS, Noel Melville | Director | Little Hadlow Bagshot Road Worplesdon Hill GU22 0QY Woking Surrey | England | British | Company Director | 3551810001 | ||||||||
STONE, James Leslie, Director | Director | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Land Director | 162183340001 | ||||||||
WESLEY, David John | Director | Harpley Hall Harpley PE31 6TL Kings Lynn Norfolk | British | Farm Manager | 17449190001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lands Improvement Holdings Limited | 06 abr 2016 | 140 London Wall EC2Y 5DN London 15th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene BRITISH FIELD PRODUCTS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 04 ago 2016 Entregado el 18 ago 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Lands improvement holdings landmatch S.à.R.l land at haddenham aerodrome, haddenham. (Title number: BM233773). Land on the north west side of dollicott, haddenham. (Title number: BM114573). Lands improvement holdings landmatch S.à.R.l land at high leigh hoddesdon. (Title number: HD399112). Note: please see debenture for further details. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 09 ene 1996 Entregado el 19 ene 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 22 ago 1991 Entregado el 30 ago 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 18 jul 1985 Entregado el 06 ago 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a £10,000,000 revolving loan facility & all other monies due of any account whatsoever | |
Breve descripción Equitable charge over all estate & inte rests in any f/h and l/h property assingnment of goodwill subject to redimption discharge of the liabilities secured by the mortgage debenture floating charge and the undertaking & all other property and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Memorandum of deposit | Creado el 19 ene 1982 Entregado el 20 ene 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £970,000 | |
Breve descripción F/Hold property at nocton, lincolnshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Memorandum of deposit | Creado el 23 nov 1979 Entregado el 12 dic 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £2,180,000 | |
Breve descripción (1) land at lytham st. Anne's, lancashire (2) land comprised in H.M. land registry, title nos la 432824, la 304154, la 304155, la 304156, la 304157. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 01 ago 1979 Entregado el 27 dic 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £970,000 | |
Breve descripción Bairnkine farm, southdean, roxburnghshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Memo of deposit | Creado el 01 dic 1975 Entregado el 02 dic 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £3,210,000 | |
Breve descripción The nocton estate,nocton, nr lincoln lincs. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Memo of deposit | Creado el 27 mar 1972 Entregado el 28 mar 1972 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £717,715 | |
Breve descripción Harpley hall farm harpley, norfolk & plantation, redmere, & decoy farms near mildenhall. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Memo of deposit | Creado el 19 oct 1971 Entregado el 20 oct 1971 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £90,000 | |
Breve descripción Fir tree & cross bank farms feltwell norfolk. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 15 abr 1965 Entregado el 05 may 1965 | Satisfecho en su totalidad | ||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0