FROZEN ASSETS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFROZEN ASSETS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00467083
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FROZEN ASSETS LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra FROZEN ASSETS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Greencore Group Uk Centre
    Midland, Way Barlborough Links
    S43 4XA Bus Park, Barlborough
    Chesterfield
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FROZEN ASSETS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CREAMERY FARE CONTINENTAL ICE CREAM LIMITED08 abr 194908 abr 1949

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FROZEN ASSETS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta24 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FROZEN ASSETS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cuentas completas preparadas hasta el 24 sept 2010

    11 páginasAA

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    3 páginasMG02

    Estado de capital el 17 ene 2011

    • Capital: GBP 2
    4 páginasSH19

    Cese del nombramiento de William Barratt como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Diane Walker como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anthony Hynes como director

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Commence winding up 16/09/2010
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 04 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Cese del nombramiento de Caroline Bergin como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Conor O Leary como director

    3 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 sept 2009

    6 páginasAA

    Nombramiento de Michael Evans como director

    3 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 04 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 26 sept 2008

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 28 sept 2007

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas preparadas hasta el 29 sept 2006

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de FROZEN ASSETS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WORDSWORTH, Gordon
    1 Home Farm Court
    Hickleton
    DN5 7AR Doncaster
    South Yorkshire
    Secretario
    1 Home Farm Court
    Hickleton
    DN5 7AR Doncaster
    South Yorkshire
    British34197470001
    EVANS, Michael
    Midland Way
    Barlborough Links Business Park
    S43 4XA Barlborough
    Uk Centre
    Chesterfield
    United Kingdom
    Director
    Midland Way
    Barlborough Links Business Park
    S43 4XA Barlborough
    Uk Centre
    Chesterfield
    United Kingdom
    United KingdomBritish148060720001
    O LEARY, Conor
    Carrigabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co Wexford
    Ireland
    Director
    Carrigabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co Wexford
    Ireland
    IrelandIrish152215930001
    WALKER, Diane Susan
    Manton Wood Enterprise Park
    Retford Road
    S80 2RS Worksop
    Greencore Food To Go
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Manton Wood Enterprise Park
    Retford Road
    S80 2RS Worksop
    Greencore Food To Go
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish156683540001
    CHALK, Richard Neil
    48 Aldwark
    YO1 7BU York
    Secretario
    48 Aldwark
    YO1 7BU York
    British52277340002
    LIDDAMENT, Michael Gordon
    28 Gredington Close
    LL13 9DQ Wrexham
    Secretario
    28 Gredington Close
    LL13 9DQ Wrexham
    British32865050003
    ROBINSON, Harry
    21 Riverhead
    Sprotbrough
    DN5 7QT Doncaster
    South Yorkshire
    Secretario
    21 Riverhead
    Sprotbrough
    DN5 7QT Doncaster
    South Yorkshire
    British1442220001
    RUSHWORTH, Alison Anne
    4a Osborne Mews
    SL4 3DE Windsor
    Berkshire
    Secretario
    4a Osborne Mews
    SL4 3DE Windsor
    Berkshire
    British39895630001
    SCOTT, Nigel George
    2 Paddock Drive
    Parkgate
    CH64 6TQ South Wirral
    Merseyside
    Secretario
    2 Paddock Drive
    Parkgate
    CH64 6TQ South Wirral
    Merseyside
    British152627130001
    ARPINO, Robert Anthony
    96 The Spinney
    HP9 1SA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    96 The Spinney
    HP9 1SA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British73236020001
    BALL, Christopher John
    The Old Rectory
    East End, Walkington
    HU17 8RY Beverley
    Director
    The Old Rectory
    East End, Walkington
    HU17 8RY Beverley
    United KingdomBritish105078650001
    BARRATT, William Harrison
    3 Sycamore Close
    DN22 7JP Retford
    Nottinghamshire
    Director
    3 Sycamore Close
    DN22 7JP Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish100531360001
    BERGIN, Caroline Margaret
    8 Holyrood Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Dublin 4
    Republic Of Ireland
    Director
    8 Holyrood Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Dublin 4
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish89332200002
    BROOKS, Peter
    7 Kendal Close
    NN10 0QE Rushden
    Northamptonshire
    Director
    7 Kendal Close
    NN10 0QE Rushden
    Northamptonshire
    British73976550003
    CHALK, Richard Neil
    48 Aldwark
    YO1 7BU York
    Director
    48 Aldwark
    YO1 7BU York
    British52277340002
    CROOK, John Raymond
    Bryn Gwiog House
    Rhosemor Road
    CH7 5QP Hendre Nr Mold
    Director
    Bryn Gwiog House
    Rhosemor Road
    CH7 5QP Hendre Nr Mold
    British2015000001
    GRIMWOOD, Michael John
    5 Swan Lane
    Bunbury
    CW6 9RA Tarporley
    Cheshire
    Director
    5 Swan Lane
    Bunbury
    CW6 9RA Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish44032280001
    HEATH, Terence Alan
    25 Alyngton
    Northchurch
    HP4 3XP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    25 Alyngton
    Northchurch
    HP4 3XP Berkhamsted
    Hertfordshire
    British36588170001
    HIGGINSON, Kevin Mark
    The Beeches, Myrtle Lodge Farm
    Main Street
    LE65 2TY Smisby
    Leicestershire
    Director
    The Beeches, Myrtle Lodge Farm
    Main Street
    LE65 2TY Smisby
    Leicestershire
    United KingdomBritish116296480001
    HYNES, Anthony Martin
    The Piggeries Hassop
    DE45 1NW Bakewell
    Derbyshire
    Director
    The Piggeries Hassop
    DE45 1NW Bakewell
    Derbyshire
    EnglandIrish100467690002
    LIDDAMENT, Michael Gordon
    28 Gredington Close
    LL13 9DQ Wrexham
    Director
    28 Gredington Close
    LL13 9DQ Wrexham
    British32865050003
    PITTMAN, Isobel Margaret
    2 Chesterton Avenue
    Hawarden
    CH5 3TP Deeside
    Clwyd
    Director
    2 Chesterton Avenue
    Hawarden
    CH5 3TP Deeside
    Clwyd
    British41937120002
    ROBINSON, Harry
    21 Riverhead
    Sprotbrough
    DN5 7QT Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    21 Riverhead
    Sprotbrough
    DN5 7QT Doncaster
    South Yorkshire
    British1442220001
    RUSHWORTH, Alison Anne
    4a Osborne Mews
    SL4 3DE Windsor
    Berkshire
    Director
    4a Osborne Mews
    SL4 3DE Windsor
    Berkshire
    British39895630001
    SCOTT, Nigel George
    2 Paddock Drive
    Parkgate
    CH64 6TQ South Wirral
    Merseyside
    Director
    2 Paddock Drive
    Parkgate
    CH64 6TQ South Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish152627130001
    SIMONS, John Michael
    Riverdale Lodge
    Ferry Green
    DE65 6BL Willington
    Derbyshire
    Director
    Riverdale Lodge
    Ferry Green
    DE65 6BL Willington
    Derbyshire
    British37634780005
    SMITH, Gerard Arthur
    158 Bawtry Road
    Bassacarr
    DN4 7BT Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    158 Bawtry Road
    Bassacarr
    DN4 7BT Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish111889550001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WOODALL, Frederick Peter
    The Ridge Pine Walks
    Prenton
    CH42 8NF Wirral
    Merseyside
    Director
    The Ridge Pine Walks
    Prenton
    CH42 8NF Wirral
    Merseyside
    British74795530001

    ¿Tiene FROZEN ASSETS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 25 mar 1986
    Entregado el 01 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £800,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/Hold 303 elveden road willesden london title no. Ngl 229915 f/hold 305 elveden road willesden, london. Title no. NGL208154.
    Personas con derecho
    • The Norwich Union Life Insurance Society.
    Transacciones
    • 01 abr 1986Registro de una carga
    • 13 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 21 ene 1983
    Entregado el 21 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    303 elveden road, brent london NW10 title number ngl 229915 and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 ene 1983Registro de una carga
    • 30 nov 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 22 dic 1982
    Entregado el 05 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 4TH may 1970.
    Breve descripción
    A specific charge over the benefit of all bookdebts and other debts present and future.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1983Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0