HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00485700 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED?
- Otra minería y extracción de piedra, n.c.o.p. (08990) / Explotación de minas y canteras
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Second Floor, Arena Court Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ARC MARINE LIMITED | 16 may 1986 | 16 may 1986 |
| A.R.C.MARINE LIMITED | 25 ago 1950 | 25 ago 1950 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Thomas William Harris como director el 17 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Henry Sherwood como director el 13 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 79 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 41 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Simon Lloyd Willis el 02 oct 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 42 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mark Henry Sherwood como director el 04 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de James Stuart Whitelaw como director el 04 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Brian Charleton como director el 04 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Jeremy Lees Dawes como director el 04 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Simon Lloyd Willis el 03 abr 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Gary James Langton el 03 abr 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Hanson Building Products (2003) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 abr 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Hanson House 14 Castle Hill Maidenhead SL6 4JJ a Second Floor, Arena Court Crown Lane Maidenhead Berkshire SL6 8QZ el 03 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 40 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Jeremy Lees Dawes el 27 jun 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Alfredo Quilez Somolinos como director el 13 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Carsten Matthias Wendt como director el 13 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 42 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Dr Carsten Matthias Wendt el 01 jul 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Gary James Langton como director el 17 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS, Wendy Fiona | Secretario | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | 206027100001 | |||||||
| CHARLETON, Brian | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | United Kingdom | British | 165494750001 | |||||
| GRETTON, Edward Alexander | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 130888540002 | |||||
| HARRIS, Thomas William | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 342970930001 | |||||
| LANGTON, Gary James | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 283491510001 | |||||
| QUILEZ SOMOLINOS, Alfredo | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | Spanish | 287317590001 | |||||
| WILLIS, Simon Lloyd | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | English | 117465520002 | |||||
| ASPINALL, David Charles | Secretario | Shingle Quay Manor Court, Hamble SO31 4GB Southampton Hampshire | British | 74352290001 | ||||||
| DRANSFIELD, Graham | Secretario | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | British | 4655640001 | ||||||
| PHILLIPS, Marilyn Jane | Secretario | 151 Chalvington Road Chandlers Ford SO53 3EL Eastleigh Hampshire | British | 34427090004 | ||||||
| SMITH, Andrew Timothy | Secretario | 8 Wiltshire Gardens Bransgore BH23 8BJ Christchurch Dorset | British | 71560280001 | ||||||
| TUNNACLIFFE, Paul Derek | Secretario | 6 Ashburnham Park KT10 9TW Esher Surrey | British | 127202460001 | ||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Secretario | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | British | 113777700001 | ||||||
| ASPINALL, David Charles | Director | Shingle Quay Manor Court, Hamble SO31 4GB Southampton Hampshire | British | 74352290001 | ||||||
| ATKINSON, Mark Roger | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | British | 232721530001 | |||||
| ATKINSON, Mark Roger | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | British | 165494900001 | |||||
| BAGNALL, Joseph Michael | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | British | 95313450001 | |||||
| BAXTER, David | Director | 1 Old Bakery Yard Middlebrook Street SO23 8DQ Winchester Hampshire | British | 65152700002 | ||||||
| BOLTER, Andrew Christopher | Director | 110 North View Road Crouch End N8 7LP London | British | 90294620001 | ||||||
| CHARLETON, Brian | Director | 21 Rydal Gardens Ashby De La Zouch LE65 1FJ Leicester Leicestershire | British | 95745960004 | ||||||
| CLARKE, David Jonathan | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | British | 160732500001 | |||||
| COOPER, Daniel John | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | United Kingdom | Australian | 203902330001 | |||||
| COULSON, Ruth | Director | Flat 4 14 Steeles Road NW3 4SE London | Australian | 109716390001 | ||||||
| DAGIM, Yuval | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | Israeli | 133454880002 | |||||
| DAWES, Jeremy Lees | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 194990720002 | |||||
| DAY, Gareth James | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | British | 121694180002 | |||||
| DENNETT, Barry | Director | Cotes 1a Coldeast Way, Sarisbury Green SO31 7AT Southampton Hampshire | British | 55396760003 | ||||||
| DENNETT, Barry | Director | 197 Swanwick Lane Swanwick SO31 7GY Southampton Hampshire | British | 55396760001 | ||||||
| DEVRIESE, Frank Rene Edmond | Director | Jonetlaan 18 1640 St Genesius-Rode FOREIGN Brussels Belgium | Belgian | 51978240001 | ||||||
| DEVULDER, Jacques Ghislain | Director | Sneppenpad No 5 8301 Knokke Heist Belgium | Belgian | 32962480002 | ||||||
| DOUGAL, Andrew James Harrower | Director | 10 Westerdale Drive Frimley GU16 5RB Camberley Surrey | British | 42737230001 | ||||||
| DRANSFIELD, Graham | Director | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | England | British | 4655640001 | |||||
| EDWARDS, Guy Charles | Director | The Street BA3 4HN Chilcompton Church View Somerset | England | British | 136493130001 | |||||
| EGAN, David John | Director | Valley Road WD3 4BJ Rickmansworth 70 Hertfordshire | United Kingdom | British | 324778100001 | |||||
| FERNLEY, Simon Roger | Director | The Coach House Manor Drive Bathford BA1 7TY Bath | England | British | 33922880002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HANSON AGGREGATES MARINE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanson Building Products (2003) Limited | 06 abr 2016 | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0