MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00512988 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED?
| Dirección de la sede social | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MAGNET & SOUTHERNS (SUPPLEMENTARY TRUSTEES) LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| LEICESTERSHIRE TIMBER COMPANY (MELTON) LIMITED | 04 nov 1952 | 04 nov 1952 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 ene 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Graham Philip Brisley Veal como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Blades como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 ene 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Maurice Delon Jones el 05 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Prima Secretary Limited el 05 ene 2010 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Nombramiento de Michael James Kachmer como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Doerr como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Adrian David Gray como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Director | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Director | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| KACHMER, Michael James | Director | Marywood Trail Wheaton 14 Illinois 60187 United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Director | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| BARKER, John David | Secretario | 2 Farnham Close Baildon BD17 6SF Shipley West Yorkshire | British | 356220001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Secretario | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| BARKER, John David | Director | 2 Farnham Close Baildon BD17 6SF Shipley West Yorkshire | British | 356220001 | ||||||||||
| BERTRAND, Marc Lawrence | Director | 545 Otley Road Adel LS16 7PH Leeds West Yorkshire | England | British | 67798220001 | |||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Director | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| BRAY, Kenneth Ivor | Director | Garden Cottage Church Street Denton NG32 1LE Grantham Lincolnshire | British | 45153770001 | ||||||||||
| DOERR, Thomas | Director | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| FAVELL, Gary Alan | Director | Yates House Foldshaw Lane Braithwaite HG3 4AN Harrogate Yorks | United Kingdom | British | 107699240001 | |||||||||
| FINDLER, Jonathan Paul | Director | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | 45532880003 | ||||||||||
| FOULKES, John Harold | Director | Cedar Tree House Main Street NN12 8EZ Farthingstone Northampshire | British | 1657980001 | ||||||||||
| GRATTON, Gordon Cameron Paul | Director | 1 Beckside Gardens LS16 5QZ Leeds West Yorkshire | England | British | 121813940001 | |||||||||
| HAMMOND, Roy | Director | Graimberg Tasburgh Road Saxlingham Thorpe NR15 1LN Norwich Norfolk | British | 30717020001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Director | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| KOK, Willem | Director | The Cottage Kildwick Hall Kildwick BD20 9AE Keighley West Yorkshire | Dutch | 68732290001 | ||||||||||
| LEE, Paul Allan | Director | Clifton Park Road Caversham RG4 7PD Reading 4 Berkshire | England | British | 70564410001 | |||||||||
| MCILROY, Michael | Director | Mayfield Bent Cottages 301 Keighley Road BB8 7HE Colne Lancashire | British | 63014400001 | ||||||||||
| MULHALL, Denis Joseph | Director | Fitzgeorge House Fitzgeorge Avenue KT3 4SH New Malden Surrey | England | British,Irish | 32235150003 | |||||||||
| O'CONNOR, Patrick Finbarr | Director | 66 Cumberland Mills Square E14 3BJ London | British | 81267460001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Director | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| WILLIAMS, David Whittow | Director | Holies Shaw House Stichens Green RG8 9SX Streatley West Berkshire | United Kingdom | British | 96167780001 |
¿Tiene MAGNET GROUP SUPPLEMENTARY TRUSTEES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creado el 16 ago 1974 Entregado el 22 ago 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including & goodwill uncalled capital. (See doc 44). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0