DATASURE HOLDINGS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DATASURE HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00513363 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DATASURE HOLDINGS LIMITED?
- Otras ediciones de software (58290) / Información y comunicación
- Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra DATASURE HOLDINGS LIMITED?
Dirección de la sede social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DATASURE HOLDINGS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DATASURE HOLDINGS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 jul 2020 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tina Anne Gough como director el 07 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Maruf Ahmad Majed como director el 26 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 jul 2019 | 12 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Modification des détails de Xchanging Global Insurance Systems Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 sept 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AQ | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AQ | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AQ a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 08 ago 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 03 jul 2018
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Maruf Ahmad Majed como director el 31 mar 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas Anthony Wilson como director el 31 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Tina Anne Gough como director el 09 jun 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nicholas Anthony Wilson como director el 09 jun 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David William Hart Gray como director el 07 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DATASURE HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOODFINE, Michael Charles | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | Solictor | 208597210001 | ||||
CAMPBELL, Kenneth Francis | Secretario | 9 Cheldon Barton SS1 3TX Thorpe Bay Essex | British | Accountant | 101302400001 | |||||
FUSSELL, Christopher Mark | Secretario | 2 Acris Street SW18 2QP London | British | 63476510003 | ||||||
GALLAGHER, Anthony James | Secretario | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | Irish | Solicitor / Chartered Secretar | 127048740001 | |||||
LONEY, Nicholas John | Secretario | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
SCORE, Timothy | Secretario | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
WILKINSON, Sidney James | Secretario | 67 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 1138390001 | ||||||
HEXAGON REGISTRARS LIMITED | Secretario corporativo | Ten Dominion Street EC2M 2EE London | 4004080002 | |||||||
BAUERNFEIND, David Gregory | Director | The Coachouse Bathampton Lane BA2 6SW Bath | United Kingdom | British | Accountant | 99529910001 | ||||
BINNS, Andrew Michael | Director | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | United Kingdom | British | Executive Director | 165907890001 | ||||
BLIGH, Andrew William | Director | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | United Kingdom | British | Cfo | 165498010001 | ||||
CAMPBELL, Kenneth Francis | Director | 9 Cheldon Barton SS1 3TX Thorpe Bay Essex | British | Accountant | 101302400001 | |||||
CROOM, Timothy Llewellyn | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 184906470001 | ||||
DEWS, Stephen Eric | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | England | British | Finance Director | 172816160001 | ||||
GOGEL, Robert Neil, Mr. | Director | 16 Av Emile Deschanel FOREIGN Paris 75007 France | France | Us/French | Chief Executive Officer | 151744580001 | ||||
GOUGH, Tina Anne | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | None Supplied | 229756300001 | ||||
GRAY, David William Hart | Director | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | None Supplied | 224241390001 | ||||
HOUGHTON, Richard Alexander | Director | 4 The Quillot Burwood Park KT12 5BY Walton On Thames Surrey | England | Irish | Finance Director | 119279790001 | ||||
LAKING, David Albert | Director | 33 Station Road Nassington PE8 6QB Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | Company Director | 82424930001 | ||||
LONEY, Nicholas John | Director | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | Company Director | 8511300001 | |||||
LORIA, Giovanni | Director | Pancras Square N1C 4AG London One Pancras Square England | England | British | Company Executive | 134764880002 | ||||
MAJED, Maruf Ahmad | Director | One Pancras Square King's Cross N1C 4AG London Dxc United Kingdom | Singapore | American | None Supplied | 245085610001 | ||||
PICKETT, Mark Jeremy | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | England | British | Cfo | 210493320001 | ||||
PRESLAND, Peter Eric | Director | Rats Castle Castletons Oak Cranbrook Road TN27 8DY Biddenden Ashford Kent | England | British | Company Director | 7649630002 | ||||
PRIGGEN, John Edward Frederick | Director | 34 Leadenhall Street London EC3A 1AX | England | British | Accountant | 128934910003 | ||||
SCORE, Timothy | Director | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | Company Director | 103319060001 | |||||
SUMMERS, Roger Denis | Director | Florins Birchwood Road Cock Clarks CM3 6PR Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Company Director | 8559710002 | ||||
WILSON, Craig Alaister | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | England | British | Regional General Manager | 173234520001 | ||||
WILSON, Nicholas Anthony | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | United Kingdom | British | None Supplied | 229755750001 | ||||
WILSON, Stewart Roger Devine | Director | Monkton House Warminster Road Monkton Combe BA2 7AZ Bath Avon | British | Finance Director | 8714780001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DATASURE HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xchanging Global Insurance Systems Limited | 21 nov 2016 | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para DATASURE HOLDINGS LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
01 jun 2017 | 20 nov 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que existe una persona registrable en relación con la empresa, pero no la ha identificado. |
¿Tiene DATASURE HOLDINGS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A supplemental debenture | Creado el 09 jul 1999 Entregado el 28 jul 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein) | |
Breve descripción All freehold and leasehold property and all assets and undertakings. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 18 mar 1999 Adquirido el 21 jul 2000 Entregado el 07 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due | |
Breve descripción Rebus computer services limited charges by way of first fixed charge all right title and interest in plant machinery & equipment, debts and claims, the proceeds of the collection of debts, benefit of insurances, goodwill & uncalled capital, intellectual property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A charge over shares of campion limited | Creado el 18 mar 1999 Adquirido el 15 oct 1999 Entregado el 02 nov 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due | |
Breve descripción 1,000 ordinary shares of £1 each and 200 deferred shares of 1P each in campion together with including all dividends etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 18 mar 1999 Entregado el 30 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the debenture and the finance documents (as defined therein) | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 21 mar 1996 Entregado el 27 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene DATASURE HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0