WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED

WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWHEWAY HAMPSHIRE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00516469
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    • (7487) /

    ¿Dónde se encuentra WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL)LLP
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ATLAS (HAMPSHIRE) LIMITED02 dic 199302 dic 1993
    WRIGHT RAIN LIMITED26 feb 195326 feb 1953

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    3 páginas4.72

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 08 sept 2010

    LRESEX

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    6 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Domicilio social registrado cambiado de Begbies Traynor (Central) Llp 2 Collingwood Street Newcastle upon Tyne NE1 1JF el 07 sept 2010

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5DR el 07 sept 2010

    2 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    13 páginasAA

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    15 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    18 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    19 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas190

    ¿Quiénes son los directivos de WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SOHAL, Balkar
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    Secretario
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    British122186580001
    LILLY, Kevin Lucius
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Director
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican110636870001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Director
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    REILLY, Michael Andrew
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    Director
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    United StatesAmerican103500870001
    M.R. SERVICES LIMITED
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Secretario corporativo
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    55567600012
    MR SERVICES LIMITED
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secretario corporativo
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    55567600003
    WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secretario corporativo
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    39955810002
    BOSWELL, Brian Peter
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    British52804120001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Director
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Director
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    British42980510001
    COOK, Norman Joseph
    69 Northbourne Avenue
    BH10 6DQ Bournemouth
    Dorset
    Director
    69 Northbourne Avenue
    BH10 6DQ Bournemouth
    Dorset
    British29686540001
    COTTON, Richard John
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    Director
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    EnglandBritish45397090001
    DAMEN, Michael John
    Chartmead 360 Vale Road
    Ash Vale
    GU12 5LW Aldershot
    Hampshire
    Director
    Chartmead 360 Vale Road
    Ash Vale
    GU12 5LW Aldershot
    Hampshire
    British21170030001
    DETHERIDGE, Ian Martin
    81 Dalkeith Court
    Dudsbury Avenue
    BH22 8DY Ferndown
    Dorset
    Director
    81 Dalkeith Court
    Dudsbury Avenue
    BH22 8DY Ferndown
    Dorset
    British48986470001
    DOHERTY, James Patrick
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Director
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Irish105328280001
    FITCHFORD, Andrew Michael John
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Director
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    British99141670001
    GOPSILL, Michael Clement
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    Director
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    British32481900001
    HAZLEHURST, Ian James
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    Director
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    British43476760001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    British33223550001
    JONES, Alan Martin
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    British47891670001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Director
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    LADENBERGER, Daniel Timothy
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Director
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    American110032170001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Director
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    British62509010002
    MUNDELL, James Joseph
    Woodcote Barn
    B61 9EE Dodford
    Worcestershire
    Director
    Woodcote Barn
    B61 9EE Dodford
    Worcestershire
    United KingdomBritish13970540001
    WALKER, Craig Allen
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Director
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Usa109340980001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Director
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    American95572300001

    ¿Tiene WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Cross guarantee and debenture
    Creado el 04 abr 2003
    Entregado el 09 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transacciones
    • 09 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 dic 1992
    Entregado el 07 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents (as defined) or any of them
    Breve descripción
    See doc ref M76 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas "Security Trustee" for the Beneficiaries (Asdefined)
    Transacciones
    • 07 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 29 jun 1988
    Entregado el 13 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jul 1988Registro de una carga
    Guarantee & debenture.
    Creado el 11 feb 1987
    Entregado el 19 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to barclay inust international limited as trustee for the lenders as defined under the terms of the facility letter of even dated and the guarantee & debenture
    Breve descripción
    Floating charge over all the undertaking property, assets and rights whatsoever present and/or future of the company.
    Personas con derecho
    • Cin Industrial Investment Limited.
    • Barclay Trust International Limitedas Trustee for Schroder UK Venture Fund And
    Transacciones
    • 19 feb 1987Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 11 feb 1987
    Entregado el 18 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Harwood road littlehampton aram west sussex t/n wsx 74999 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1987Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 11 feb 1987
    Entregado el 18 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Crowe arch lane ringwood new forest hampshire t/n hp 73054. and/or proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1987Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 11 feb 1987
    Entregado el 18 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property known as all that land lying on the east side of crowe arch lane ringwood hampshire and/or proceeds of salethereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1987Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 11 feb 1987
    Entregado el 18 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1987Registro de una carga

    ¿Tiene WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 sept 2010Inicio de la liquidación
    21 may 2011Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter Andrew Blair
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    Profesional
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    Andrew D Haslam
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Profesional
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0