H.& S.OPENSHAW LIMITED

H.& S.OPENSHAW LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaH.& S.OPENSHAW LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00516501
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de H.& S.OPENSHAW LIMITED?

    • (5138) /

    ¿Dónde se encuentra H.& S.OPENSHAW LIMITED?

    Dirección de la sede social
    19 Copse Road
    FY7 6RP Fleetwood
    Lancashire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de H.& S.OPENSHAW LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 mar 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para H.& S.OPENSHAW LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 07 feb 2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Paul Gower como director

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 ene 2011 au 30 jun 2011

    1 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 4 57 Sandgate Street London England SE15 1LE United Kingdom el 04 ene 2011

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Paul Matthew Gower como director

    2 páginasAP01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 17 dic 2010

    • Capital: GBP 3,362,614
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Toby Baxendale como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Taylor Foods Limited como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de Unit a15/a19 New Covent Garden Market 9 Elms London SW8 5EE el 10 nov 2010

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 13 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Toby Oliver James Baxendale el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Stephen Andrew Oswald el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Taylor Foods Limited el 01 oct 2009

    2 páginasCH02

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 mar 2009

    26 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de H.& S.OPENSHAW LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OSWALD, Stephen Andrew
    Hadham Road
    CM23 2QR Bishop's Stortford
    12
    Herts
    Secretario
    Hadham Road
    CM23 2QR Bishop's Stortford
    12
    Herts
    BritishAccountant129688190001
    OSWALD, Stephen Andrew
    Hadham Road
    CM23 2QR Bishop's Stortford
    12
    Herts
    Director
    Hadham Road
    CM23 2QR Bishop's Stortford
    12
    Herts
    EnglandBritishAccountant129688190001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    6 Cumbrae Drive
    Stanney Oaks
    CH65 9JX Ellesmere Port
    Cheshire
    Secretario
    6 Cumbrae Drive
    Stanney Oaks
    CH65 9JX Ellesmere Port
    Cheshire
    BritishDirector112657600001
    HOSKER, Peter Benjamin
    10 Ambrose Drive
    Didsbury
    M20 2YE Manchester
    Greater Manchester
    Secretario
    10 Ambrose Drive
    Didsbury
    M20 2YE Manchester
    Greater Manchester
    BritishFinance Director116270530001
    KAY, Sandra Patricia
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Lancashire
    Secretario
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Lancashire
    BritishFishmonger7721770002
    BATESON, Michael Jonathan
    33 Springhead Mills
    Springhead Road
    BD22 7RZ Keighley
    West Yorkshire
    Director
    33 Springhead Mills
    Springhead Road
    BD22 7RZ Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director84494860001
    BAXENDALE, Toby Oliver James
    Ayot Bury
    AL6 9BG Ayot St Peter
    Hertfordshire
    Director
    Ayot Bury
    AL6 9BG Ayot St Peter
    Hertfordshire
    United KingdomBritishEntrepreneur107950400001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    Director
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    United KingdomBritishDirector151680990001
    FITTON, Jeremy Rossler, Mr.
    Waystead Close
    Kingsmead
    CW9 8NN Northwich
    2
    Cheshire
    Director
    Waystead Close
    Kingsmead
    CW9 8NN Northwich
    2
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director132712400001
    GOWER, Paul Matthew
    Copse Road
    FY7 6RP Fleetwood
    19
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Copse Road
    FY7 6RP Fleetwood
    19
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector41943830006
    HOSKER, Peter Benjamin
    10 Ambrose Drive
    Didsbury
    M20 2YE Manchester
    Greater Manchester
    Director
    10 Ambrose Drive
    Didsbury
    M20 2YE Manchester
    Greater Manchester
    BritishFinance Director116270530001
    KAY, Peter Dale
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Director
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    BritishFishmonger7721780002
    KAY, Sandra Patricia
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Lancashire
    Director
    Hailwood
    44 Arley Lane Haigh
    WN1 2UQ Wigan
    Lancashire
    BritishFishmonger7721770002
    KNOWLES, Raymond
    520 St Helens Road
    BL3 3SJ Bolton
    Lancashire
    Director
    520 St Helens Road
    BL3 3SJ Bolton
    Lancashire
    BritishFishmonger17154510001
    LAWTON, Mark John
    7 Cambrian Way
    Ewloe
    CH5 3RE Deeside
    Clwyd
    Director
    7 Cambrian Way
    Ewloe
    CH5 3RE Deeside
    Clwyd
    United KingdomBritishOperations Director134828320001
    MEDLICOTT, Nigel Gerald
    25 Eden Street
    Astley Bridge
    BL1 6NL Bolton
    Director
    25 Eden Street
    Astley Bridge
    BL1 6NL Bolton
    BritishFishmonger17154490003
    OWEN, Geoffrey Frank
    29 Queens Place
    Summerseat
    BL9 5PH Bury
    Lancashire
    Director
    29 Queens Place
    Summerseat
    BL9 5PH Bury
    Lancashire
    BritishManager52422420002
    PARNELL, Christine
    1 Redshaw Avenue
    Turton Heights
    BL2 3FL Bolton
    Lancashire
    Director
    1 Redshaw Avenue
    Turton Heights
    BL2 3FL Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishFinance Director17154500003
    WESTON, Leo George
    6 Ashfield Road
    WA15 9QJ Altrincham
    Cheshire
    Director
    6 Ashfield Road
    WA15 9QJ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director74534820006
    WOODWARD, Jeremy Alan
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    Director
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    United KingdomBritishDirector57016650004
    TAYLOR FOODS LIMITED
    New Covent Garden Market
    Nine Elms
    SW8 5EE London
    A15-A19
    England
    United Kingdom
    Director corporativo
    New Covent Garden Market
    Nine Elms
    SW8 5EE London
    A15-A19
    England
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3795013
    140220750001

    ¿Tiene H.& S.OPENSHAW LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 01 sept 2009
    Entregado el 03 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 03 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 31 jul 2009
    Entregado el 08 ago 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 2009Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 21 abr 2009
    Entregado el 29 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re: h & s openshaw limited and numbered 00777608 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 30 nov 2005
    Entregado el 08 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/a fishermans wharf mile st bolton. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage deed
    Creado el 17 nov 2004
    Entregado el 19 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fisherman's wharf nile st bolton t/no: GM499696. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    All assets debenture
    Creado el 13 oct 2004
    Entregado el 21 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 21 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 13 oct 2004
    Entregado el 20 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 oct 2004
    Entregado el 20 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 mar 1989
    Entregado el 16 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that l/h land together with the buildings erected thereon fronting to nile street bolton greater manchester. Fixed charge over all movable plant mac hinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 mar 1989Registro de una carga
    • 26 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 ene 1982
    Entregado el 29 ene 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transacciones
    • 29 ene 1982Registro de una carga
    • 26 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0