SPX INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SPX INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00517486 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SPX INTERNATIONAL LIMITED?
- Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor Alexander House, 4 Station Road SK8 5AE Cheadle Hulme United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GENERAL SIGNAL UK LIMITED | 05 ene 1993 | 05 ene 1993 |
| LEEDS & NORTHRUP LIMITED | 21 mar 1953 | 21 mar 1953 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor, Alexander House 4 Station Road Cheadle Hulme SK8 5AE United Kingdom a C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor Alexander House, 4 Station Road Cheadle Hulme SK8 5AE el 22 dic 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mark Edward Shanahan el 14 abr 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Spx Uk Holding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 mar 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Eversheds Llp, Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5DR a C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor, Alexander House 4 Station Road Cheadle Hulme SK8 5AE el 14 abr 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 sept 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Martyn Greaves como director el 30 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital el 21 abr 2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 35 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jaime Manson Easley el 15 mar 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Tsoris como director el 31 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Peter James Ryan como director el 31 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Jaime Manson Easley como director el 17 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASLEY, Jaime Manson | Director | 13320 Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte Spx Flow Inc. North Carolina United States | United States | American | 259841060001 | |||||
| RYAN, Peter James | Director | Ballantyne Corporate Place 28277 Charlotte 13320 North Carolina United States | United States | American | 259841080001 | |||||
| SHANAHAN, Mark Edward | Director | Part Ground Floor Alexander House, 4 Station Road SK8 5AE Cheadle Hulme C/O Spx Flow Europe Limited United Kingdom | England | British | 165707440001 | |||||
| BRICKER, Ross Benjamin | Secretario | 2401 Pioneer Road JI 60201 Evanston Illinios Ji 60201 Usa | Canadian | 105172080001 | ||||||
| CONNELL, John Gregory | Secretario | 2 Larch Rise Prestbury SK10 4UY Macclesfield Cheshire | British | 16795230001 | ||||||
| GRAY, Harold | Secretario | 6 Pownall Avenue Bramhall SK7 2HE Stockport Cheshire | British | 16795240001 | ||||||
| KEARNEY, Christopher James | Secretario | 14675 Rudolph Dadey Drive Charlotte Nc2827749456 Usa | American | 85114770001 | ||||||
| LILLY, Kevin Lucius | Secretario | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 Usa | American | 110636870001 | ||||||
| SEATON, John Charles | Secretario | 22 The Moorives Malahida Dublin Ireland | British | 32740720001 | ||||||
| ARTHUR, Raymond Lawrence | Director | 64b Pelham Lane 06877 Ridgefield Connecticut Usa | British | 56821140001 | ||||||
| BOBER, Joanne Leslie | Director | 300 East 75th Street New York City 10021 New York Usa | American | 50979870001 | ||||||
| BOUCHARD, William | Director | Bray Cottage 30 Station Road RG17 9UR Kintbury Berkshire | American | 79426700001 | ||||||
| BRICKER, Ross Benjamin | Director | 2401 Pioneer Road JI 60201 Evanston Illinios Ji 60201 Usa | Canadian | 105172080001 | ||||||
| CAHILL, Paul Andrew | Director | Hambridge Road RG14 5TR Newbury Spx International Limited Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 202085370001 | |||||
| CONNELL, John Gregory | Director | 2 Larch Rise Prestbury SK10 4UY Macclesfield Cheshire | Uk | British | 16795230001 | |||||
| COOK, Iain Wallace | Director | 102 Poplar Road Dorridge B93 8DG Solihull West Midlands | England | British | 4924770001 | |||||
| CROSS, Arthur Robert | Director | 1188 Harbour Point Drive Muskegon Michigan Mi 49441 Usa | American | 61807880001 | ||||||
| CULL, Jonathan Peter | Director | 35 Elmwood M33 5RN Sale Cheshire | British | 42815760001 | ||||||
| CULLY, Ian Tyrell | Director | 104 Rue Des Suresnes 92000 Nanterre France | British | 40875280001 | ||||||
| GERACI, Eugene Edward | Director | 114 Brasail The Bailey Howth Dublin Ireland | Usa | 39590220001 | ||||||
| GRAY, Harold | Director | 6 Pownall Avenue Bramhall SK7 2HE Stockport Cheshire | British | 16795240001 | ||||||
| GREAVES, John Martyn | Director | Hambridge Road RG14 5TR Newbury Spxflow Berkshire United Kingdom | England | British | 246468860001 | |||||
| KEARNEY, Christopher James | Director | 14675 Rudolph Dadey Drive Charlotte Nc2827749456 Usa | American | 85114770001 | ||||||
| LILLY, Kevin Lucius | Director | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 Usa | United States | American | 110636870001 | |||||
| MORTIMER, Terry James | Director | 20 Buttonball Lane Weston Connecticut 06883 America | American | 52291630001 | ||||||
| O'LEARY, Patrick Joseph | Director | 6524 Chipstead Lane 28277 Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | United States | American | 61807850002 | |||||
| PARK, Samuel Edward | Director | 662 Alexander Spring Road Carlisle Pennsylvania 17013 Usa | Irish | 35202230001 | ||||||
| REILLY, Michael Andrew | Director | 2007 Channelstone Way NC 28104 Matthews Nc 28104 Usa | United States | American | 103500870001 | |||||
| SELLS, David William | Director | The Old Vicarage Acklington Morpoth Northumberland | British | 68623080001 | ||||||
| SMELTSER, Jeremy Wade | Director | Ballantyne Corporate Place 28277 Charlotte 13515 North Carolina United States | United States | American | 163313000001 | |||||
| SMITH, Edgar James | Director | High Ridge Park 06904 Stamford Connecticut 06904 Usa | American | 16897690001 | ||||||
| SOHAL, Balkar | Director | Hambridge Road RG14 5TR Newbury C/O Spx Flow Technology Limited Berkshire United Kingdom | England | English | 161546310001 | |||||
| TSORIS, Stephen | Director | Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte 13320 North Carolina United States | United States | American | 197069810001 | |||||
| TWOMBLY, Julian Ballard | Director | 1 Running Brook Lane New Canaan 06840 Connecticut United States Of America | American | 38022940001 | ||||||
| WINOWIECKI, Ronald Lee | Director | 8707 Calumet Farms Drive Wexham Nc 28173 Usa | American | 95572300001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spx Uk Holding Limited | 06 abr 2016 | Part Ground Floor, Alexander House 4 Station Road SK8 5AE Cheadle Hulme C/O Spx Flow Europe Limited United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SPX INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 09 feb 2005 Entregado el 22 feb 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All that piece of parcel of f/h land k/a unit 5 buttington cross enterprise park, welshpool, powys together with the building or buildings erected thereon or on part thereof. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge of deposit | Creado el 10 feb 2004 Entregado el 17 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposit initially of £2,990,265.00 credited to account designation 63057972 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency, description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0