THE COLD CHAIN FEDERATION
Visión general
| Nombre de la empresa | THE COLD CHAIN FEDERATION |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 00517554 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE COLD CHAIN FEDERATION?
- Actividades de organizaciones profesionales de miembros (94120) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra THE COLD CHAIN FEDERATION?
| Dirección de la sede social | Unit 7 Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE COLD CHAIN FEDERATION?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE FOOD STORAGE AND DISTRIBUTION FEDERATION | 25 ago 2010 | 25 ago 2010 |
| THE FOOD STORAGE AND DISTRIBUTION FEDERATION LTD | 24 dic 2008 | 24 dic 2008 |
| THE COLD STORAGE AND DISTRIBUTION FEDERATION | 09 may 1990 | 09 may 1990 |
| NATIONAL COLD STORAGE FEDERATION(THE) | 23 mar 1953 | 23 mar 1953 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE COLD CHAIN FEDERATION?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE COLD CHAIN FEDERATION?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 09 abr 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 23 abr 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 abr 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE COLD CHAIN FEDERATION?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Claire Suzanne Ashby Walters como director el 01 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Dr Henry Clarke como director el 22 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Anthony Wall como director el 22 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 13 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Matthew O'dell como director el 06 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 14 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Jonathon Robert Miles como director el 15 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Phillip Edward Pluck en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 dic 2023 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Shane Patrick Brennan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 dic 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Mr Phillip Edward Pluck como secretario el 31 dic 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Shane Patrick Brennan como secretario el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Shane Patrick Brennan como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Phillip Edward Pluck como director el 20 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Edward James Green como director el 11 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 14 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Claire Suzanne Ashby Walters como director el 05 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Moran como director el 05 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 14 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Paul Philip Jukes como director el 25 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Kevin Barry Hancock como director el 25 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Edward James Green como director el 25 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE COLD CHAIN FEDERATION?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUCK, Phillip Edward | Secretario | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | 317698890001 | |||||||
| BACKHOUSE, James Anderson | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 19317050002 | |||||
| BALDWIN, Andrew Lyndon | Director | Allerton Close DL7 8NX Northallerton 17 North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125322060002 | |||||
| BENNELL, Paul Michael | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 111647150001 | |||||
| CLARKE, Henry, Dr | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 336329560001 | |||||
| COTTER, Dermot Joseph, Dr | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 248474280001 | |||||
| HANCOCK, Kevin Barry | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 239472890004 | |||||
| JUKES, Paul Philip | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | United Kingdom | British | 296463310001 | |||||
| JUNIPER, Lee Scott | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 213016300001 | |||||
| LAWRENCE, Andrew Campbell | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 200213500002 | |||||
| MARTIN, Paul Andrew | Director | Langthwaite Road Langthwaite Grange Ind Estate, South Kirkby WF9 3AP Pontefract Joseph Martin House Unit 18/20 West Yorkshire England | United Kingdom | British | 63460100005 | |||||
| O'DELL, Matthew | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 193516080001 | |||||
| PLUCK, Phillip Edward | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 237093160001 | |||||
| WALL, Anthony | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 95193200001 | |||||
| WOODWARD, James Peter | Director | Racecourse Road SY10 7PN Oswestry Underhill Farm Shropshire United Kingdom | England | British | 124338190001 | |||||
| BITTLES, William James | Secretario | 7 Peatmoor Close Church Road GU51 4LE Fleet Hampshire | British | 66524450001 | ||||||
| BRENNAN, Shane Patrick | Secretario | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | 250293220001 | |||||||
| HUTCHINGS, John | Secretario | 2 Heath Close RG41 2PG Wokingham Berkshire | British | 54798800001 | ||||||
| STURMAN, Christopher John | Secretario | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 United Kingdom | British | 66650520004 | ||||||
| ATKINSON, Martin John | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 195083480001 | |||||
| BAYLY, Geoffrey Michael | Director | Coneys Bighton SO24 9RE Alresford Hampshire | British | 6207420001 | ||||||
| BEEVER, Ian Paul | Director | 30 Ashbrooke Monkseaton NE25 8EG Whitley Bay Tyne & Wear | British | 8336630001 | ||||||
| BLANCH, Martin | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 194842910001 | |||||
| BRENNAN, Shane Patrick | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 250294360002 | |||||
| BROWN, Ernest Gerald Freeman | Director | Lily Rose 10 Elsley Road Tilehurst RG31 6RN Reading Berkshire | England | British | 60315730001 | |||||
| BROWN, Robert Collins | Director | 41 Prestwick Road KA8 8LE Ayr Ayrshire | British | 8336600001 | ||||||
| BUIJZE, Duco Robert Gijsbert | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | Netherlands | Dutch | 188912100001 | |||||
| BYRNE, Paul Christopher | Director | Leckhampstead East Reigate Road RH2 0QT Reigate Surrey | United Kingdom | British | 488470002 | |||||
| BYRNE, Paul Christopher | Director | Leckhampstead East Reigate Road RH2 0QT Reigate Surrey | United Kingdom | British | 488470002 | |||||
| CAMPION, Raymond Vincent | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | Irish | 122519940002 | |||||
| CLARK, John Milne | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 10915800002 | |||||
| CLARK, John Milne | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 United Kingdom | England | British | 10915800002 | |||||
| COOKE, Gordon Leslie | Director | 92 High Street Wrestlingworth SG19 2EJ Sandy Bedfordshire | British | 34718600001 | ||||||
| COWLEY, Russell Andrew | Director | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | England | British | 184108270002 | |||||
| DAVIS, Frederick William | Director | Old Vicarage North Road Gedney Hill PE12 0NL Spalding Lincolnshire | British | 8336550001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE COLD CHAIN FEDERATION?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Phillip Edward Pluck | 31 dic 2023 | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Shane Patrick Brennan | 11 sept 2018 | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Christopher John Sturman | 01 jul 2016 | Diddenham Court Lambwood Hill Grazeley RG7 1JQ Reading Unit 7 | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0