ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED

ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00521510
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    • (4521) /

    ¿Dónde se encuentra ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Dirección de la sede social
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RYAN UTILITY SERVICES LIMITED20 nov 200020 nov 2000
    D.J. RYAN & SONS LIMITED07 jul 195307 jul 1953

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2009
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2010
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta17 oct 2016
    Próxima declaración de confirmación vence31 oct 2016
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 28 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 28 sept 2018

    2 páginasTM02

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Andrew Wilkins como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 17 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 oct 2009

    Estado de capital el 22 oct 2009

    • Capital: GBP 1,449,628
    SH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    05 dic 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    6 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2007

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a
    Anotaciones
    FechaAnotación
    05 dic 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    11 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a
    Anotaciones
    FechaAnotación
    05 dic 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2006

    5 páginasAA

    legacy

    15 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COFFEY, Stephanie Helen
    53 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LY Reading
    Berkshire
    Secretario
    53 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LY Reading
    Berkshire
    British81328280002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Secretario
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Secretario
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    British24075160004
    HIGGINS, Caroline Patricia
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    Secretario
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    British88102970001
    MEADOWS, John
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    Secretario
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    British101833160001
    STONES, Michael John
    23 Muirfield Close
    Fulwood
    PR2 7EA Preston
    Lancashire
    Secretario
    23 Muirfield Close
    Fulwood
    PR2 7EA Preston
    Lancashire
    British68468490001
    ARMSTRONG, Neil Patrick
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Director
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Irish104897110001
    BROOKES, Philip
    Tudor House
    Lime Tree Avenue
    LS23 6DP Boston Spa
    West Yorkshire
    Director
    Tudor House
    Lime Tree Avenue
    LS23 6DP Boston Spa
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89559990001
    BROWN, David Robertson
    11 Dorchester Road
    Fixby
    HD2 2JZ Huddersfield
    Director
    11 Dorchester Road
    Fixby
    HD2 2JZ Huddersfield
    United KingdomBritish39067610002
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Director
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish11806560001
    CAROLAN, Peter Vincent
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Director
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Irish62299930001
    COCKER, Neil David
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    Director
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish260158230001
    DARBYSHIRE, John Peter
    12 Salisbury Drive
    M25 0HU Prestwich
    Manchester
    Director
    12 Salisbury Drive
    M25 0HU Prestwich
    Manchester
    British69930320002
    FOX, Kenneth
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    Director
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish15540580001
    FRASER, Richard
    4 Severn Hill
    Fulwood
    PR2 3RD Preston
    Lancashire
    Director
    4 Severn Hill
    Fulwood
    PR2 3RD Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish79090001
    GREENHALGH, Donald
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    Director
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    British47084170002
    GREENOUGH, Michael Robert
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    Director
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    British53010640001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Director
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Director
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    LANSOM, Stewart Paul
    23 Park Street
    FY8 5LU Lytham
    Lancashire
    Director
    23 Park Street
    FY8 5LU Lytham
    Lancashire
    British79070008
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Director
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    LAWLESS, Dennis Arthur
    14 Sevenoaks
    PR7 3NS Chorley
    Lancashire
    Director
    14 Sevenoaks
    PR7 3NS Chorley
    Lancashire
    British46658890003
    LEACH, William Anthony
    17 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    Director
    17 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    British66732560001
    MEADOWS, John
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    Director
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    EnglandBritish101833160001
    MEMMOTT, Robert William
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    Director
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    British109306950001
    MILLS, Lee James
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish53951880001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Director
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    ROWAN, Michael William
    Jinbabyne 1 Field Farm Drive
    Edingale
    B79 9LF Tamworth
    Staffordshire
    Director
    Jinbabyne 1 Field Farm Drive
    Edingale
    B79 9LF Tamworth
    Staffordshire
    British72210350002
    RYAN, Daniel Joseph
    Button Mill
    Inglewhite
    PR3 2LE Preston
    Lancashire
    Director
    Button Mill
    Inglewhite
    PR3 2LE Preston
    Lancashire
    British1472220001
    RYAN, John Timothy Anthony
    Bank Hall
    Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Director
    Bank Hall
    Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    British39428900001
    RYAN, Michael Bernard
    Stafford House 102 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 4NN Preston
    Lancashire
    Director
    Stafford House 102 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 4NN Preston
    Lancashire
    British779240001
    SIMCOCK, Barry
    24 Poplar Drive
    ST3 3AZ Blurton
    Staffordshire
    Director
    24 Poplar Drive
    ST3 3AZ Blurton
    Staffordshire
    British74253700001
    WILKINS, Andrew Michael
    PR25
    Director
    PR25
    United KingdomBritish125411390001
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Director corporativo
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007

    ¿Tiene ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattels mortgage
    Creado el 05 sept 2001
    Entregado el 05 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattles plant machinery, 16 compressor & generator systems, 2 x computer servers (for further details please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 05 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 12 feb 1992
    Entregado el 21 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Premises situate in station road pembroke dyfed.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 1992
    Entregado el 05 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the north west side of rough hey road preston lancashire t/n la 585346.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 1992
    Entregado el 05 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the north east side of rough hey road, preston, lancashire. T/n la 525 287.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 1992
    Entregado el 05 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All those premises known as longridge foundry, inglewhite road, (formerly higher lane) longridge, lancashire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 ene 1992
    Entregado el 05 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Please see doc form M395 reference M198C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Credit agreement
    Creado el 05 abr 1991
    Entregado el 16 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 172590.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Breve descripción
    All right title & interest in & to all sums payable (including by way of refund) under the insurance whereof are set out on form 395 (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 16 abr 1991Registro de una carga
    • 10 feb 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 24 ene 1990
    Entregado el 08 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future includin book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 feb 1990Registro de una carga
    • 10 feb 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 ago 1988
    Entregado el 01 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Premises situated off rough hey road, preston.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 01 sept 1988Registro de una carga
    • 10 feb 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 abr 1988
    Entregado el 14 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the north east side of rough hey road preston.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 14 abr 1988Registro de una carga
    • 10 feb 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 14 dic 1971
    Entregado el 22 dic 1971
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and premises at longridge foundry, longridge in the county of lancaster with all fixtures.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 22 dic 1971Registro de una carga
    • 10 feb 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0