ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00521510 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
- (4521) /
¿Dónde se encuentra ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Dirección de la sede social | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RYAN UTILITY SERVICES LIMITED | 20 nov 2000 | 20 nov 2000 |
| D.J. RYAN & SONS LIMITED | 07 jul 1953 | 07 jul 1953 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2009 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2010 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2008 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 oct 2016 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 31 oct 2016 |
| Vencido | Sí |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 28 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 28 sept 2018 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Wilkins como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 oct 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2007 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
legacy | 11 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2006 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 15 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEY, Stephanie Helen | Secretario | 53 Kidmore Road Caversham RG4 7LY Reading Berkshire | British | 81328280002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Secretario | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secretario | Blackbarn House Main Street Bishampton WR10 2NH Pershore Worcestershire | British | 24075160004 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Secretario | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| MEADOWS, John | Secretario | 39 Beech Walk Pennington WN7 3LL Leigh Lancashire | British | 101833160001 | ||||||
| STONES, Michael John | Secretario | 23 Muirfield Close Fulwood PR2 7EA Preston Lancashire | British | 68468490001 | ||||||
| ARMSTRONG, Neil Patrick | Director | 4 Euxton Hall Gardens Euxton PR7 6PB Chorley Lancashire | Irish | 104897110001 | ||||||
| BROOKES, Philip | Director | Tudor House Lime Tree Avenue LS23 6DP Boston Spa West Yorkshire | United Kingdom | British | 89559990001 | |||||
| BROWN, David Robertson | Director | 11 Dorchester Road Fixby HD2 2JZ Huddersfield | United Kingdom | British | 39067610002 | |||||
| BROWN, John Ernest | Director | 10 Stonegate Fold Heath Charnock PR6 9DX Chorley Lancashire | England | British | 11806560001 | |||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Director | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| COCKER, Neil David | Director | 5 Rossett Close Kingsmead CW9 8WP Northwich Cheshire | England | British | 260158230001 | |||||
| DARBYSHIRE, John Peter | Director | 12 Salisbury Drive M25 0HU Prestwich Manchester | British | 69930320002 | ||||||
| FOX, Kenneth | Director | 5 Sandiacre Standish WN6 0TJ Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 15540580001 | |||||
| FRASER, Richard | Director | 4 Severn Hill Fulwood PR2 3RD Preston Lancashire | United Kingdom | British | 79090001 | |||||
| GREENHALGH, Donald | Director | The Hayricks Bolton Road PR6 9HN Anderton Lancashire | British | 47084170002 | ||||||
| GREENOUGH, Michael Robert | Director | Millstone Cottage Bolton Road PR6 9HJ Anderton Lancashire | British | 53010640001 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Director | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Director | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| LANSOM, Stewart Paul | Director | 23 Park Street FY8 5LU Lytham Lancashire | British | 79070008 | ||||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LAWLESS, Dennis Arthur | Director | 14 Sevenoaks PR7 3NS Chorley Lancashire | British | 46658890003 | ||||||
| LEACH, William Anthony | Director | 17 Claybank Drive Tottington BL8 4BU Bury Lancashire | British | 66732560001 | ||||||
| MEADOWS, John | Director | 39 Beech Walk Pennington WN7 3LL Leigh Lancashire | England | British | 101833160001 | |||||
| MEMMOTT, Robert William | Director | Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DN Warrington Cheshire | British | 109306950001 | ||||||
| MILLS, Lee James | Director | 4 Kings Court CM23 2AA Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| O'BRIEN, Neil Christopher | Director | Alexandra House 11 St Catherine Drive Hartford CW8 2FE Northwich Cheshire | British | 58219210001 | ||||||
| ROWAN, Michael William | Director | Jinbabyne 1 Field Farm Drive Edingale B79 9LF Tamworth Staffordshire | British | 72210350002 | ||||||
| RYAN, Daniel Joseph | Director | Button Mill Inglewhite PR3 2LE Preston Lancashire | British | 1472220001 | ||||||
| RYAN, John Timothy Anthony | Director | Bank Hall Sawley BB7 4RS Clitheroe Lancashire | British | 39428900001 | ||||||
| RYAN, Michael Bernard | Director | Stafford House 102 Victoria Road Fulwood PR2 4NN Preston Lancashire | British | 779240001 | ||||||
| SIMCOCK, Barry | Director | 24 Poplar Drive ST3 3AZ Blurton Staffordshire | British | 74253700001 | ||||||
| WILKINS, Andrew Michael | Director | PR25 | United Kingdom | British | 125411390001 | |||||
| AM NOMINEES LIMITED | Director corporativo | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 34427260007 |
¿Tiene ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Chattels mortgage | Creado el 05 sept 2001 Entregado el 05 sept 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All and singular the chattles plant machinery, 16 compressor & generator systems, 2 x computer servers (for further details please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 12 feb 1992 Entregado el 21 feb 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Premises situate in station road pembroke dyfed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 ene 1992 Entregado el 05 feb 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land on the north west side of rough hey road preston lancashire t/n la 585346. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 ene 1992 Entregado el 05 feb 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land on the north east side of rough hey road, preston, lancashire. T/n la 525 287. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 ene 1992 Entregado el 05 feb 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All those premises known as longridge foundry, inglewhite road, (formerly higher lane) longridge, lancashire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 27 ene 1992 Entregado el 05 feb 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Please see doc form M395 reference M198C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Credit agreement | Creado el 05 abr 1991 Entregado el 16 abr 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 172590.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Breve descripción All right title & interest in & to all sums payable (including by way of refund) under the insurance whereof are set out on form 395 (see form 395 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 24 ene 1990 Entregado el 08 feb 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future includin book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 31 ago 1988 Entregado el 01 sept 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Premises situated off rough hey road, preston. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 12 abr 1988 Entregado el 14 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land on the north east side of rough hey road preston. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 14 dic 1971 Entregado el 22 dic 1971 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and premises at longridge foundry, longridge in the county of lancaster with all fixtures. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0