VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED

VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00525186
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DOEFLEX INDUSTRIES LIMITED30 oct 195330 oct 1953

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Memorándum y Estatutos

    13 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Estado de capital el 12 oct 2021

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 11 oct 2021

    • Capital: GBP 1,173,110
    3 páginasSH01

    Estado de capital el 08 oct 2021

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 07 oct 2021

    • Capital: GBP 11,427,644
    3 páginasSH01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2020 au 28 feb 2021

    1 páginasAA01

    Cambio de datos del director Mr Ian William Robb el 16 jul 2021

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 26 abr 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Estado de capital el 06 nov 2020

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    4 páginasSH20

    legacy

    4 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 03/11/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    8 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Secretario corporativo
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro1031815
    109599980003
    O'RIORDAN, Daniel Joseph, Mr.
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Director
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish176979900001
    ROBB, Ian William
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Director
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    United KingdomBritish263073080001
    ROUND, Darren Lee
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Director
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish100922110001
    SHAFI KHAN, Mohammed Omar
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Director
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    United KingdomBritish239506860001
    DENT, John
    Hazeldene Station Approach East
    Earlswood
    RH1 6JH Redhill
    Surrey
    Secretario
    Hazeldene Station Approach East
    Earlswood
    RH1 6JH Redhill
    Surrey
    British12774290001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Secretario
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    British78366970002
    TEAGUE, Alan Richard
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    Secretario
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    British290650004
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Secretario
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    British12317760001
    BICKERTON, Richard Henry Cheetham
    Send Grove
    Church Lane, Send
    GU23 7JL Woking
    Surrey
    Director
    Send Grove
    Church Lane, Send
    GU23 7JL Woking
    Surrey
    EnglandBritish12360020001
    BURLEY, Nicholas James
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Director
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish122799590001
    CHEELE, Jonathan Mark
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Director
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish127959950003
    DAVIES, Michael Gomer
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Director
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    UkBritish154115450002
    DURKIN, Thomas Frederick
    An Cala
    5 Dover Road, Branksome Park
    BH13 6DZ Poole
    Director
    An Cala
    5 Dover Road, Branksome Park
    BH13 6DZ Poole
    EnglandBritish83598360002
    ECCLES, Colin
    Fourwinds 23 Sandilands
    CR0 5DF Croydon
    Surrey
    Director
    Fourwinds 23 Sandilands
    CR0 5DF Croydon
    Surrey
    British12360030001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    Director
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    EnglandBritish105961550001
    HARRIS, Howard Elliott
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    Director
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    British93378750001
    HAY, Nigel Bruce
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Director
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish124316170001
    JOHNSON, David John
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Director
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish150755940001
    MAUNDRELL, Graham Lloyd
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Director
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish56093930002
    MELTHAM, John David
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Director
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish74570910001
    O'CONNOR, Calvin James John
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    Director
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish16253240001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Director
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritish78366970002
    TEAGUE, Alan Richard
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    Director
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    British290650004
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Director
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    EnglandBritish12317760001
    WRIGHT, Paul Martin
    c/o Vita Cellular Foams (Uk) Limited
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    N/A
    England
    Director
    c/o Vita Cellular Foams (Uk) Limited
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    N/A
    England
    UkBritish150691780001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Vita (Group) Unlimited
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    06 abr 2016
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Unlimited Company
    País de registroU.K.
    Autoridad legalEnglish Law
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registro871669
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattel mortgage
    Creado el 01 may 1995
    Entregado el 09 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Mixer combination -papenmeier- TSHK750 mixer/KGU2500 cooler serial no 5277 two screw extruder - battenfield - serial no 89 -8172 -51. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 24 mar 1995
    Entregado el 06 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Mixer combination - paper meir 5277 two screw extruder - battenfeld 89-8172-51. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of pledge of goods with third party pledgee
    Creado el 24 nov 1994
    Entregado el 28 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 14TH september 1994 for a term loan in the amount of bef 49,000,000
    Breve descripción
    Line no.2 Specialised thin polypropylene line incorporating the pieces of machinery listed on the schedule to the form 395. all pieces of machinery are located at the premises of horizon industries N.V. at kruinegemstraat 92, 9200 schoten belguim. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kredietbank Nv
    Transacciones
    • 28 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 oct 1991
    Entregado el 07 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or hereafter to become due from the company to the bank on any account whatsoever
    Breve descripción
    Legal mortgage all the f/h and l/h property of the company. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 20 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 30 nov 1987
    Entregado el 07 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1987Registro de una carga
    • 28 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 dic 1985
    Entregado el 30 dic 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land on the north side of holmethorpe avenue, reigate, surrey t/n - sy 161638.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1985Registro de una carga
    • 28 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 jul 1984
    Entregado el 30 jul 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/Hold 42/44 holmethorpe avenue redhill surrey title no sy 508628.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jul 1984Registro de una carga
    • 28 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Further guarantee debenture
    Creado el 02 feb 1981
    Entregado el 11 feb 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed & further deed.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 feb 1981Registro de una carga
    Guarantee & debenture
    Creado el 27 mar 1980
    Entregado el 09 abr 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or kensingear limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings, fixtures fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 1980Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 21 dic 1967
    Entregado el 09 ene 1968
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 75000
    Breve descripción
    Land factory & premises at holmethorpe redhill & land factory & premises 145 frenches rd, redhill.
    Personas con derecho
    • Phoenix Assurance Company LTD
    Transacciones
    • 09 ene 1968Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 13 jun 1960
    Entregado el 02 jun 1960
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc
    Breve descripción
    Undertaking and all property and goodwill present and future including uncalled capital. See doc 25 for details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 jun 1960Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0