NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED

NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00533432
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15th Floor 6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Lisa Susanne Gray como director el 15 jul 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Estado de capital el 08 abr 2022

    • Capital: GBP 3.131
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Sheraz Afzal como director el 06 abr 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Marie-Anne Bousaba como director el 29 mar 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 09 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020

    8 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN England a 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA el 12 nov 2020

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019

    8 páginasAA

    Nombramiento de Ms Lisa Gray como director el 06 sept 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Sheraz Afzal como director el 06 sept 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Justin Staadecker como director el 06 sept 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Andrew James Smith como director el 08 may 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Tony Deakin como director el 01 dic 2018

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England a Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN el 12 sept 2018

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ASHLEY, Jonathan
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Director
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    EnglandAmerican243850150001
    BOUSABA, Marie-Anne
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Director
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    United KingdomAustralian293005440001
    BIONDI, Lorna
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Secretario
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    196292540001
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secretario
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secretario
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GOLD, Nick
    126 Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UT London
    Secretario
    126 Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UT London
    British111562560001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HARRINGTON, Nicholas Joseph
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    Secretario
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    British1273670001
    MCKENZIE, Robbie
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secretario
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    195400050001
    PAGE, Elizabeth
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    Secretario
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    British34006010001
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secretario
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    178737250001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Secretario
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Irish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Secretario
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    WALTON, Caroline Debra
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Secretario
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    British151330230001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Director
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish55757700003
    AFZAL, Sheraz
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Director
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    United KingdomBritish251073350001
    ATTALLAH, Naim Ibrahim
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    Director
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    United KingdomBritish25646240001
    BERKMEN, Gillian
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    Director
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    GbBritish92154270001
    BROWN, Andrew Saville
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    Director
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritish69874610002
    BRYAN, Robert Andrew
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Director
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandBritish122733810001
    CLAYMAN, Paul Sidney
    18 Keepier Wharf
    12 Narrow Street
    E14 8DH London
    Director
    18 Keepier Wharf
    12 Narrow Street
    E14 8DH London
    British14436120006
    COOPER, Caroline
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    Director
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    British92733900001
    COREPAL, Sanjiv Kumar
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Director
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    United KingdomBritish205239750001
    DAHL, Ian Xavier
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    Director
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    British66486140001
    DEAKIN, Tony
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Director
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    United KingdomBritish210862440001
    ERICKSON, Eric George
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Director
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaUsa224104020001
    EVANS, Nicholas David
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    Director
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    United KingdomBritish57490310002
    FILECCIA, Piero
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Director
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandBritish116096800001
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Director
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GOLD, Nicholas Paul
    126 Hamilton Terrace
    St Johns Wood
    NW8 9UT London
    Director
    126 Hamilton Terrace
    St Johns Wood
    NW8 9UT London
    EnglandBritish53606570002
    GRAY, Lisa Susanne
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Director
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    EnglandBritish262153810001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HIBBERD, Roy Wayne
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Director
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    UsaUnited States158609380001
    HOWARD, Stuart John
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Director
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    EnglandBritish192909600002
    JOHNSON-POENSGEN, Douglas Howard
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Director
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish192481000001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Dmwsl 488 Limited
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    England
    06 abr 2016
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEnglish Law
    Autoridad legalEnglish Law
    Lugar de registroRegister Of Uk Companies, Companies House
    Número de registro05575201
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 nov 2005
    Entregado el 06 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transacciones
    • 06 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties
    Creado el 05 jun 2001
    Entregado el 13 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 13 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company amnd the agent
    Creado el 24 dic 1998
    Entregado el 02 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transacciones
    • 02 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 24 dic 1998
    Entregado el 02 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (and each of them) which shall for the avoidance of doubt include the debenture and guarantee set out therein
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankboston N.A. (As Agent for the Lenders)
    Transacciones
    • 02 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 29 jun 1995
    Entregado el 06 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All of each charging companys right title and interest in and to "the real property" as defined in 395 together with fixed charge all right title and interest in and to the "investments" (as defined in the security assignment) and all rights and assets belonging to the relevant charging company deriving from such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Secured Creditors
    Transacciones
    • 06 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 07 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0