HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00537430 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Second Floor, Arena Court Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ARC CONCRETE LIMITED | 12 may 1986 | 12 may 1986 |
| A.R.C. CONCRETE LIMITED | 06 sept 1982 | 06 sept 1982 |
| A.R.C. CONCRETE (NORTHERN) LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| CHARCON PIPES LIMITED | 27 ago 1954 | 27 ago 1954 |
| CHARCON PIPES & TUNNELS LIMITED | 27 ago 1954 | 27 ago 1954 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 26 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 12 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 26 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 78 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 26 feb 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 26 feb 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 9 páginas | AA | ||
Modification des détails de Hanson Building Products (2003) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 abr 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Hanson House 14 Castle Hill Maidenhead SL6 4JJ a Second Floor, Arena Court Crown Lane Maidenhead Berkshire SL6 8QZ el 03 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Carsten Matthias Wendt como director el 23 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Alfredo Quilez Somolinos como director el 23 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 18 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Dr Carsten Matthias Wendt el 01 jul 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 feb 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Dr Carsten Matthias Wendt como director el 01 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Jonathan Clarke como director el 01 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS, Wendy Fiona | Secretario | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | 206034740001 | |||||||
| BENNING-PRINCE, Nicholas Arthur Dawe, Mr. | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 182670630001 | |||||
| DOWLEY, Robert Charles | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 183842720001 | |||||
| GRETTON, Edward Alexander | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | British | 130888540002 | |||||
| QUILEZ SOMOLINOS, Alfredo | Director | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | England | Spanish | 287317590001 | |||||
| DRANSFIELD, Graham | Secretario | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | British | 4655640001 | ||||||
| FERNLEY, Simon Roger | Secretario | The Coach House Manor Drive Bathford BA1 7TY Bath | British | 33922880002 | ||||||
| LANCASTER, Amanda Dawn | Secretario | Moss Lane Elstow MK42 9YT Bedford 16 Bedfordshire United Kingdom | British | 139696290001 | ||||||
| PETERS, Ian Alan Duncan | Secretario | Rectory Stables Gay Street BA11 3PT Mells Somerset | British | 154498310001 | ||||||
| TUNNACLIFFE, Paul Derek | Secretario | 6 Ashburnham Park KT10 9TW Esher Surrey | British | 127202460001 | ||||||
| TYLER, Ian Paul | Secretario | Lime Tree House 3b Village Road, Cockayne Hatley SG19 2EE Sandy Bedfordshire | British | 66794160001 | ||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Secretario | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | British | 113777700001 | ||||||
| VARCOE, Richard Antony Bruce, Dr | Secretario | 105 Thingwall Park Fishponds BS16 2AR Bristol | British | 55610930001 | ||||||
| VIVIAN, Simon Neil | Secretario | Pond Farm Cottage Faulkland BA3 5YG Bath Somerset | British | 97479630001 | ||||||
| CLARKE, David Jonathan | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House Berkshire England | England | British | 160732500001 | |||||
| CLAYDON, James Alexander | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | British | 109198860004 | |||||
| COOK, Jonathan David | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | United Kingdom | British | 132940150001 | |||||
| DRANSFIELD, Graham | Director | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | England | British | 4655640001 | |||||
| FERNLEY, Simon Roger | Director | The Coach House Manor Drive Bathford BA1 7TY Bath | England | British | 33922880002 | |||||
| GIMMLER, Richard Robert | Director | Park Place Ashton Keynes SN6 6NT Wiltshire 7 Uk | British | 131676390001 | ||||||
| GUYATT, Benjamin John | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | United Kingdom | British | 131516210001 | |||||
| MEINS, John Charles | Director | 31 Butler's Court Road HP9 1SQ Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 59558870001 | |||||
| MENZIES-GOW, Robert Ian | Director | Ashwell Cottage Church Close Ashwell LE15 7LP Oakham Leicestershire | United Kingdom | British | 75693480001 | |||||
| MORTIMER, John | Director | The Bower House Mountain Bower North Wraxall SN14 7AJ Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 4028440001 | |||||
| PETERS, Ian Alan Duncan | Director | Rectory Stables Gay Street BA11 3PT Mells Somerset | England | British | 154498310001 | |||||
| PIRINCCIOGLU, Seyda | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | England | Turkish | 152863060001 | |||||
| POOLE, Trevor | Director | Meadow View 4 Hammett Close DT2 7EF Tolpuddle Dorset | England | British | 127347600001 | |||||
| SNOWDON, David John | Director | 24 South Approach HA6 2ET Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 118974700001 | |||||
| SPURR, William | Director | Summerhill House Coach Drive Quarndon DE22 5JX Derby Derbyshire | England | British | 126011000001 | |||||
| SZYMANSKI, David John | Director | Top Lane Mells BA11 3QN Frome Rossendale Somerset | England | British | 62072670001 | |||||
| TROTT, Wendy Jane | Director | 14 Partridge Lane Bromham MK43 8PQ Bedford Bedfordshire | British | 65656160001 | ||||||
| TYLER, Ian Paul | Director | Lime Tree House 3b Village Road, Cockayne Hatley SG19 2EE Sandy Bedfordshire | British | 66794160001 | ||||||
| VARCOE, Richard Antony Bruce, Dr | Director | 105 Thingwall Park Fishponds BS16 2AR Bristol | United Kingdom | British | 55610930001 | |||||
| VIVIAN, Simon Neil | Director | Pond Farm Cottage Faulkland BA3 5YG Bath Somerset | United Kingdom | British | 97479630001 | |||||
| WENDT, Carsten Matthias, Dr | Director | 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead Hanson House | Germany | German | 220319550003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HANSON CONCRETE PRODUCTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanson Building Products (2003) Limited | 06 abr 2016 | Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Second Floor, Arena Court Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0