LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00539476 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED?
| Dirección de la sede social | Level 7, 1 Eversholt Street NW1 2DN London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LEND LEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED | 14 oct 2011 | 14 oct 2011 |
| CROSBY LEND LEASE CONSTRUCTION LIMITED | 11 jul 2005 | 11 jul 2005 |
| BERKELEY CONSTRUCTION LIMITED | 10 ene 1997 | 10 ene 1997 |
| CALDWELL & SONS LIMITED | 20 oct 1954 | 20 oct 1954 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Modification des détails de Lendlease Residential (Cg) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Level 7 1 Eversholt Street London NW1 2DN United Kingdom a Level 7, 1 Eversholt Street London NW1 2DN el 20 nov 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Pinsent Masons Llp 30 Crown Place London EC2A 4ES England a Level 7 1 Eversholt Street London NW1 2DN el 03 nov 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2025 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024 | 1 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Merchant Square Level 9 London W2 1BQ England a C/O Pinsent Masons Llp 30 Crown Place London EC2A 4ES el 09 dic 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mrs Angela Gangemi como director el 31 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Dominic Leonard como director el 31 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew David Herbert-Read como director el 08 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 1 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 20 Triton Street Regent's Place London NW1 3BF a 5 Merchant Square Level 9 London W2 1BQ el 12 sept 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 1 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de John David Clark como director el 16 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Adriano Maio como director el 16 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Anthony William Smith como director el 16 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Andrew David Herbert-Read como director el 16 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mr John David Clark el 23 abr 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Peter Dominic Leonard como director el 18 feb 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Justin Davies como director el 18 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANGEMI, Angela | Director | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 304248460001 | |||||||||
| SMITH, Anthony William | Director | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 290630830001 | |||||||||
| DRAPER, Jennifer | Secretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | 217858250001 | |||||||||||
| JANANDRAN, Thanalakshmi | Secretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | British | 93299990001 | ||||||||||
| MOUL, Anthony Peter | Secretario | 3 St Charles Place KT13 8XJ Weybridge Surrey | British | 47859160002 | ||||||||||
| PUTTERGILL, Claire | Secretario | 49 Pine Gardens KT5 8LJ Surbiton Surrey | British | 49527970005 | ||||||||||
| TAYLOR, Elizabeth | Secretario | 37 Swallow Rise Knaphill GU21 2LH Woking Surrey | British | 53767920002 | ||||||||||
| WHEATCROFT, Stephen John | Secretario | 2 Meg Lane Broken Cross SK10 3LB Macclesfield | British | 66118250002 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Dukes Place EC3A 7NH London 40 England |
| 102944500001 | ||||||||||
| AVEY, Alan John | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | United Kingdom | British | 182214260001 | |||||||||
| CARTER, Nicholas Frank | Director | 23 Ladythorn Crescent Bramhall SK7 2HB Stockport | England | British | 118414250001 | |||||||||
| CLARK, John David | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | British | 224239010001 | |||||||||
| COOK, Richard John | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | England | British | 178588500002 | |||||||||
| COPPELL, Richard Andrew | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | United Kingdom | British | 140027550001 | |||||||||
| DAVIES, Justin | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | Australian | 247518540002 | |||||||||
| FRANCIS, Peter John | Director | The Priory Church Road Old Windsor SL4 2JW Windsor Berkshire | British | 33577450001 | ||||||||||
| HERBERT-READ, Andrew David | Director | Merchant Square Level 9 W2 1BQ London 5 England | United Kingdom | British | 290449820001 | |||||||||
| HUTCHINSON, Geoffrey | Director | 142 Northolt Road Harrow HA2 0EE Middlesex | United Kingdom | British | 16644000004 | |||||||||
| JACKSON, David William | Director | Parrotts Farm Parrotts Lane, HP23 6NE Cholesbury Hertfordshire | British | 88674820001 | ||||||||||
| LEONARD, Peter Dominic | Director | Merchant Square Level 9 W2 1BQ London 5 England | United Kingdom | British | 280048870001 | |||||||||
| LEWIS, Roger St John Hulton | Director | Le Bocage La Rue Du Bocage St Brelade JE3 8BP Jersey Channel Islands | Great Britain | British | 30879310004 | |||||||||
| MAIO, Adriano | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | British | 217675660001 | |||||||||
| O'ROURKE, Benjamin Michael | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | United Kingdom | Australian | 156924720001 | |||||||||
| PERRINS, Robert Charles Grenville | Director | Runnymede Sandpit Hall Road GU24 8AN Chobham Surrey | United Kingdom | British | 40362930004 | |||||||||
| PIDGLEY, Anthony William | Director | Kilbees Farm Hatchet Lane SL4 2EG Winkfield Berkshire | United Kingdom | British | 77499160001 | |||||||||
| POWELL, Malcolm | Director | Birchcroft Churchfields Sandiway CW8 2JS Northwich Cheshire | British | 15258830001 | ||||||||||
| ROPER, Graham John | Director | Summer Cottage 134a Kippington Road TN13 2LW Sevenoaks Kent | England | British | 10215970001 | |||||||||
| SEELEY, Rebecca Jayne | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | United Kingdom | British | 217722670001 | |||||||||
| STARKEY, Richard Justin | Director | 142 Northolt Road Harrow HA2 0EE Middlesex | England | British | 122099810001 | |||||||||
| STEARN, Richard James | Director | 34 Inman Road Earlsfield SW18 3BB London | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||||||
| UNITT, Adrian David | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | United Kingdom | British | 215217350001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LENDLEASE RESIDENTIAL CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendlease Residential (Cg) Limited | 06 abr 2016 | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0