KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED

KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00540556
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VENT MASTER (EUROPE) LIMITED21 jun 199621 jun 1996
    BERISFORD BAKER STREET LIMITED01 mar 199501 mar 1995
    BERISFORD TREASURY LIMITED10 feb 199510 feb 1995
    BERISFORD TREASURY LIMITED09 may 198909 may 1989
    S & W BERISFORD TREASURY LIMITED29 oct 198729 oct 1987
    ASTON METAL CO LIMITED12 nov 195412 nov 1954

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Estado de capital el 09 ago 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    3 páginasSH20

    legacy

    3 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Michael James Kachmer como director el 03 abr 2013

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    5 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Graham Philip Brisley Veal como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kevin Blades como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Thomas Doerr como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Adrian David Gray como director

    3 páginasAP01

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Secretario corporativo
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Director
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Director
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Director
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Secretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Secretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Director
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BUTLER, Peter Robert
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    Director
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    British34707070001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Director
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Director
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Director
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Director
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Director
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    JONES, Eric Alan
    Stidolphs Old Farm House
    Eggpie Lane Sevenoaks
    TN4 6NP Weald
    Kent
    Director
    Stidolphs Old Farm House
    Eggpie Lane Sevenoaks
    TN4 6NP Weald
    Kent
    British27290300001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Director
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Director designado
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Director
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director corporativo
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    Director corporativo
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    75310650002
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director corporativo
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006
    S & W BERISFORD LIMITED
    1 Farnham Road
    GU2 4RG Guildford
    Surrey
    Director corporativo
    1 Farnham Road
    GU2 4RG Guildford
    Surrey
    75310610001

    ¿Tiene KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creado el 11 abr 2002
    Entregado el 25 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 25 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creado el 20 feb 2002
    Entregado el 08 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 08 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creado el 20 nov 2001
    Entregado el 30 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge agreement
    Creado el 13 ago 1999
    Entregado el 27 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement
    Breve descripción
    All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Facility Agent
    Transacciones
    • 27 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of amendment.
    Creado el 30 sept 1991
    Entregado el 16 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) and barclays bank PLC (the replacement agent) under the terms of the debenture dated 26.9.90
    Breve descripción
    All the company's rights in the book debts & other debts, licenses, coments, authorisations etc. (see form 395 for details).
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 oct 1991Registro de una carga
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 sept 1990
    Entregado el 09 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obliger (as therein defiend) to national westminster bank PLC (the second security agent) and the banks (as threin defined) or any at them under the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berisford international PLC under the subcrdination guarantee
    Breve descripción
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 oct 1990Registro de una carga
    • 30 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 sept 1990
    Entregado el 09 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (aas therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements
    Breve descripción
    Nsee from 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 oct 1990Registro de una carga
    • 22 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0