GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD

GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00540682
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD?

    Dirección de la sede social
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ALSTOM RESOURCES MANAGEMENT LTD14 jun 200714 jun 2007
    ALSTOM CONTROLS LTD23 dic 199823 dic 1998
    CEGELEC CONTROLS LTD.01 mar 199101 mar 1991
    GEC CONTROLS LIMITED20 dic 198920 dic 1989
    GEC ELECTRICAL PROJECTS LIMITED 16 nov 195416 nov 1954

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cambio de datos del director Steven Robert Miller el 01 jul 2021

    2 páginasCH01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de St Leonards Building Harry Kerr Drive Stafford England and Wales ST16 1WT United Kingdom a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR el 04 ene 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 17 dic 2020

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    2 páginasMR04

    Estado de capital el 10 dic 2020

    • Capital: GBP 0.50
    3 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Memorándum y Estatutos

    31 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Iain Graham Ross Macdonald como director el 26 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nigel Gary Jones como director el 26 jun 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Steven Robert Miller como director el 26 jun 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de James Edward Dennison como director el 26 jun 2020

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    10 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name18 may 2020

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 15 may 2020

    RES15

    Nombramiento de Oakwood Corporate Secretary Limited como secretario el 15 may 2020

    2 páginasAP04

    ¿Quiénes son los directivos de GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro7038430
    146358090001
    DENNISON, James Edward
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Director
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishTax Director250786800001
    MILLER, Steven Robert
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Director
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishGeneral Manager244835990002
    CLEDWYN DAVIES, Altan Denys
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    Secretario
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    BritishLegal Director73335570001
    DAVIES, Bruce Boyden
    7 Chapel Fields
    Swinford
    LE17 6BS Lutterworth
    Leicestershire
    Secretario
    7 Chapel Fields
    Swinford
    LE17 6BS Lutterworth
    Leicestershire
    British51304240001
    HIBBARD, Joseph Roger
    50 Edyvean Close
    Bilton
    CV22 6LD Rugby
    Warwickshire
    Secretario
    50 Edyvean Close
    Bilton
    CV22 6LD Rugby
    Warwickshire
    BritishCompany Director57406940001
    MACDONALD, Iain Graham Ross
    St. Leonards Avenue
    ST17 4LX Stafford
    St Leonards Works
    England
    Secretario
    St. Leonards Avenue
    ST17 4LX Stafford
    St Leonards Works
    England
    155218720001
    PEERMOHAMED, Zahra
    Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark, 201
    England
    Secretario
    Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark, 201
    England
    192967230001
    PURCELL, Robert Michael
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    Secretario
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    150749200001
    REYNOLDS, Gill
    20 Calder Street
    PA12 4DD Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Secretario
    20 Calder Street
    PA12 4DD Lochwinnoch
    Renfrewshire
    BritishLegal Advisor91921020001
    AUSTIN, Helena Claire
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    Director
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    United KingdomBritishHr Director119629700001
    BAKER, Stephen Clarke
    April House
    Washpit Lane
    CV13 0EH Barlestone
    Nuneaton
    Director
    April House
    Washpit Lane
    CV13 0EH Barlestone
    Nuneaton
    BritishDirector104901840001
    BALL, Bruce Henry
    St. Leonards Avenue
    ST17 4LX Stafford
    St Leonards Works
    England
    Director
    St. Leonards Avenue
    ST17 4LX Stafford
    St Leonards Works
    England
    United KingdomCanadianVp Human Resources171788540002
    BASTID, Pierre Tristan Michel, M.
    Rue Du Docteur Siffre
    77930 Perthes
    35
    France
    Director
    Rue Du Docteur Siffre
    77930 Perthes
    35
    France
    FranceFrenchSenior Vice President133546770001
    BLENKINSOP, John Maxwell
    36 Needhill Close
    Knowle
    B93 9QS Solihull
    West Midlands
    Director
    36 Needhill Close
    Knowle
    B93 9QS Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishUk Tax Manager88765900001
    BOISSEAU, Philippe
    20 Rue Magenta
    78000 Versailles
    France
    Director
    20 Rue Magenta
    78000 Versailles
    France
    FrenchCorporate Management32935260001
    BONAFE, Pierre Raymond Jean-Louis
    26 Rue Henri De Regnier
    78000 Versailles
    France
    Director
    26 Rue Henri De Regnier
    78000 Versailles
    France
    FrenchCorporate Management35349940001
    BOWLES, Leslie Frederick
    Stamford House Station Road
    Kirby Muxloe
    LE9 2EN Leicester
    Leicestershire
    Director
    Stamford House Station Road
    Kirby Muxloe
    LE9 2EN Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector23069830001
    BURGIN, Stephen Rex
    St. Leonards Avenue
    ST17 4LX Stafford
    St Leonards Works
    England
    Director
    St. Leonards Avenue
    ST17 4LX Stafford
    St Leonards Works
    England
    EnglandBritishUk Country President92907890002
    CARR, Keith David
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    Director
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    FranceBritishGroup General Counsel151138710002
    CLEDWYN DAVIES, Altan Denys
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    Director
    Newbold Road
    Rugby
    CV21 2NH Warwickshire
    United KingdomBritishLegal Director73335570001
    CONNOR, Michael Gilmore
    2 Waters Reach
    273 Inner Promenade
    FY8 1QL Lytham St Annes
    Lancashire
    Director
    2 Waters Reach
    273 Inner Promenade
    FY8 1QL Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishDirector57943490001
    COPSON, Christopher Francis
    62 Coton Park Drive
    Coton Meadows
    CV23 0WN Rugby
    Warwickshire
    Director
    62 Coton Park Drive
    Coton Meadows
    CV23 0WN Rugby
    Warwickshire
    BritishAccountant75938330003
    DAS GUPTA, Prosanto Kumar
    The Farmhouse
    Cosford Grange Cosford
    CV21 1HT Rugby
    Warwickshire
    Director
    The Farmhouse
    Cosford Grange Cosford
    CV21 1HT Rugby
    Warwickshire
    FrenchManaging Director99037680002
    DAVIES, John Alan
    Dunsmore Cottage
    Clifton-Upon-Dunsmore
    CV23 0BB Rugby
    Warwickshire
    Director
    Dunsmore Cottage
    Clifton-Upon-Dunsmore
    CV23 0BB Rugby
    Warwickshire
    BritishDeputy Managing Director16740230001
    DE LA SERRE, Yves
    3 Bis Boulevard De La Saussaye
    92200 Neuilly Sur Seine
    France
    Director
    3 Bis Boulevard De La Saussaye
    92200 Neuilly Sur Seine
    France
    FrenchDirector48195180001
    ELBORNE, Mark Edward Monckton
    Talgarth Road
    W6 8BJ London
    201
    England
    Director
    Talgarth Road
    W6 8BJ London
    201
    England
    EnglandBritishBusiness Executive113766400001
    ELLIS, John
    The Dell
    64 Kneeton Road
    NG13 8PJ East Bridgford
    Nottinghamshire
    Director
    The Dell
    64 Kneeton Road
    NG13 8PJ East Bridgford
    Nottinghamshire
    EnglandBritishFinancial Director197053420001
    FLICKER, Mark
    56 Greenacres Drive
    Garstang
    PR3 1RQ Preston
    Lancashire
    Director
    56 Greenacres Drive
    Garstang
    PR3 1RQ Preston
    Lancashire
    BritishV P Finance94765730001
    GERARD, Michel
    79 Boulevard Suchet
    Paris 75016
    France
    Director
    79 Boulevard Suchet
    Paris 75016
    France
    FrenchCorporate Management38154130002
    GILL, Rajinder Singh
    37 West Drive
    Handsworth
    B20 3ST Birmingham
    West Midlands
    Director
    37 West Drive
    Handsworth
    B20 3ST Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant120915250001
    HIBBARD, Joseph Roger
    50 Edyvean Close
    Bilton
    CV22 6LD Rugby
    Warwickshire
    Director
    50 Edyvean Close
    Bilton
    CV22 6LD Rugby
    Warwickshire
    BritishCompany Director57406940001
    HOLYHEAD, Christian David
    St. Leonards Avenue
    ST17 4LX Stafford
    St Leonards Works
    England
    Director
    St. Leonards Avenue
    ST17 4LX Stafford
    St Leonards Works
    England
    EnglandBritishChartered Accountant169848230001
    HOME, David Alexander Cospatrick, The Earl Of Home
    99 Dovehouse Street
    SW3 6JZ London
    Director
    99 Dovehouse Street
    SW3 6JZ London
    United KingdomBritishMerchant Banker46400001
    JONES, Nigel Gary
    Stafford
    ST17 4UQ Staffordshire
    Lichfield Road
    England
    England
    Director
    Stafford
    ST17 4UQ Staffordshire
    Lichfield Road
    England
    England
    United KingdomBritishDirector212828470001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Harry Kerr Drive
    ST16 1WT Stafford
    St Leonards Building
    England And Wales
    United Kingdom
    18 ago 2017
    Harry Kerr Drive
    ST16 1WT Stafford
    St Leonards Building
    England And Wales
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04267931
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    27 oct 201618 ago 2017La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    An omnibus letter of set-off
    Creado el 14 oct 2004
    Entregado el 30 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 30 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 15 november 2002 and
    Creado el 08 sept 2004
    Entregado el 24 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    An omnibus letter of set-off
    Creado el 15 nov 2002
    Entregado el 23 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2020Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene GE POWER RESOURCES MANAGEMENT LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 dic 2020Inicio de la liquidación
    11 feb 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Colin Peter Dempster
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Derek Hyslop
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0