PAYLESS PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PAYLESS PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00543407 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
- (7012) /
¿Dónde se encuentra PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 100 Barbirolli Square M2 3EY Manchester Greater Manchester |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PAYLESS D.I.Y. LIMITED | 10 dic 1985 | 10 dic 1985 |
| TUBBS BUILDING SUPPLIES LIMITED | 01 jul 1985 | 01 jul 1985 |
| PAYLESS D.I.Y. LIMITED | 01 ene 1983 | 01 ene 1983 |
| MARLEY HOMECARE LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| MARLEY RETAIL LIMITED | 17 ene 1955 | 17 ene 1955 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 21 feb 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Aviso de cambio de la administración a la disolución el 01 may 2012 | 27 páginas | 2.35B | ||||||||||
Informe de progreso del administrador hasta 04 nov 2011 | 36 páginas | 2.24B | ||||||||||
Notificación de la aprobación presunta de las propuestas | 97 páginas | F2.18 | ||||||||||
Declaración de la propuesta del administrador | 95 páginas | 2.17B | ||||||||||
Declaración de asuntos con el formulario 2.14B/2.15B | 9 páginas | 2.16B | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr William Grimsey el 13 may 2011 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de un administrador | 1 páginas | 2.12B | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Gawsworth House Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6XB el 11 may 2011 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Brian Robbins como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Dawn Michelle Wilkinson el 11 oct 2010 | 3 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Thomas Christopher Morgan el 11 oct 2010 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Bird como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Patrick Gladwin el 11 oct 2010 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Brian Keith Robbins el 11 oct 2010 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 21 feb 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Brian Keith Robbins como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 jul 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Thomas Christopher Morgan como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Unitt como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Penelope Teale como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 22 feb 2009 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 5 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKINSON, Dawn Michelle | Secretario | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire United Kingdom | British | 105435010001 | ||||||
| GLADWIN, Robert Patrick | Director | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | 130288970001 | |||||
| GRIMSEY, William | Director | 9 The Avenue WD7 7DG Radlett Tall Timbers Hertfordshire | United Kingdom | British | 50647840004 | |||||
| MORGAN, Thomas Christopher | Director | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | 152428250002 | |||||
| BANKS, David | Secretario | Ground Floor Flat Redland Green Road BS6 7HE Bristol Avon | British | 87235970001 | ||||||
| FENNELL, Sonia | Secretario | Gilliver Cottage Gilliver Lane Clipston On The Wolds NG12 5PD Nottingham | British | 9591230004 | ||||||
| HOSKINS, William | Secretario | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | 121893830001 | ||||||
| HUGHES, Gerard Maxwell | Secretario | 53 Chesilton Road Fulham SW6 5AA London | British | 70698270002 | ||||||
| RIMMER, Barbara | Secretario | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||
| STEVENS, Philip Alan | Secretario | 31 Summit Drive IG8 8QW Woodford Green Essex | British | 9581300001 | ||||||
| WILLIAMS, David Robert | Secretario | 15 St Stephens Road CH42 8PP Prenton Merseyside | British | 157062220001 | ||||||
| WILSON, Geoffrey Charles | Secretario | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 72996700001 | ||||||
| ARCHER, William Ernest | Director | The Priory 2 Astley Close WA16 8GJ Knutsford Cheshire | British | 15170380004 | ||||||
| BANKS, David | Director | Ground Floor Flat Redland Green Road BS6 7HE Bristol Avon | British | 87235970001 | ||||||
| BIRD, Richard Sidney | Director | 80 Wolsey Road HA6 2EH Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 111500210002 | |||||
| BOWE, Alan Laurence | Director | Church View Farmhouse Church Lane, Osgathorpe LE12 9SY Loughborough Leicestershire | British | 64241650002 | ||||||
| COHEN, John Alexander | Director | 7 Rectory Gardens Wollaton NG8 2AR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 25406220001 | |||||
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Director | 3 Cottage Farm Close Osgathorpe LE12 9UE Loughborough Leicestershire | British | 52040210002 | ||||||
| GILES, Alan James | Director | Tanglewood Crowsley Road RG9 3LE Shiplake Oxfordshire | England | British | 156046020001 | |||||
| HOOD, John | Director | Briarwood 15 Twatling Road Barnt Green B45 8HX Birmingham West Midlands | British | 39644740001 | ||||||
| HOSKINS, William | Director | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | 121893830001 | ||||||
| JOHNSON, Stephen Richard | Director | The Old Vicarage Lower Dunsforth YO26 9SA York | England | British | 87398750001 | |||||
| MCDOUGAL, Robert Hugh | Director | 41 Tensing Close Great Sankey WA5 5AN Warrington Cheshire | British | 15170390002 | ||||||
| MORTON, Ivor Malcolm | Director | Lysander 8 Pine Close Shottery CV37 9FB Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 30725390003 | ||||||
| MURRAY, Stephan Peter | Director | Red Brick Barn Caythorpe NG14 7EB Nottingham Nottinghamshire | British | 53490630001 | ||||||
| PIGGOTT, Kenneth Stanton | Director | 172 Loughborough Road NG11 6LF Ruddington Nottingham | United Kingdom | British | 144061950001 | |||||
| RADFORD, Kenneth Thomas | Director | 21 Melton Road Tollerton NG12 4EL Nottingham | British | 47191400001 | ||||||
| ROBBINS, Brian Keith | Director | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | American | 153559370002 | |||||
| RUSSELL, Stephen George | Director | The Manor Barn 19b Far Street Wymeswold LE12 6TZ Loughborough Leicestershire | British | 145267530001 | ||||||
| SCRIBBINS, Rodney Martin | Director | The Hemploe Hemploe Road NN6 6HF Welford Northampton | England | British | 98160250001 | |||||
| SINCLAIR, Jonathan Stuart | Director | 57 Hallfields Edwalton NG12 4AA Nottingham | British | 45080280003 | ||||||
| TEALE, Penelope Jane | Director | 1 Weldon Rise Off Pitcher Lane MK5 8BW Loughton Milton Keynes | United Kingdom | British | 126053080001 | |||||
| THOMAS, Shelley Frances | Director | Everest Road SK14 4DX Hyde Woodside Farm Cheshire | United Kingdom | British | 133244600001 | |||||
| UNITT, Andrew Vaughan | Director | 64 Main Street LE74 4UU Cossington Hollycroft Leicester | England | British | 182500750001 | |||||
| UNITT, Andrew Vaughan | Director | 64 Main Street LE74 4UU Cossington Hollycroft Leicester | England | British | 182500750001 |
¿Tiene PAYLESS PROPERTIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security accession deed | Creado el 22 feb 2007 Entregado el 06 mar 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 19 ago 1998 Entregado el 03 sept 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due by any group company (as therein defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries, as therein defined) under the banking documents and the mezzanine loan agreement (both as therein defined) whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise and in each case under the working capital facility letter | |
Breve descripción F/H property known as bonehill road tamworth t/n SF319160, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 13 nov 1968 Entregado el 02 dic 1968 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Trust deed for further securing £5,000,000 debenture stock of the marley tile (holding) company LTD. Secured by two trust deeds dated 14/2/58 & 8/5/63 respectively. | |
Breve descripción Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene PAYLESS PROPERTIES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| En administración |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0