HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED

HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00544265
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hazlehead
    Crowedge
    S36 4HG Sheffield
    South Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    STONEWARE LIMITED05 feb 195505 feb 1955

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 18 oct 2012

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mr John Sage como director el 31 jul 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Calum James Forsyth como director el 31 jul 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 oct 2011

    Estado de capital el 26 oct 2011

    • Capital: GBP 350,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Taylor como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Keith Barker como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    2 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    14 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    14 páginasAA

    legacy

    1 páginas403b

    ¿Quiénes son los directivos de HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAYLOR, Paul William
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    Secretario
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    British62180340002
    SAGE, John
    Latimer Road
    Cropston
    LE7 7GP Leicester
    19
    United Kingdom
    Director
    Latimer Road
    Cropston
    LE7 7GP Leicester
    19
    United Kingdom
    EnglandBritish171410140001
    TAYLOR, Paul William
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    Director
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    United KingdomBritish62180340002
    PHILLIPS, Robert Glyn
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretario
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    British842980001
    BARKER, Keith Stuart
    12 Tan House Lane
    Parbold
    WN8 7HG Wigan
    Greater Manchester
    Director
    12 Tan House Lane
    Parbold
    WN8 7HG Wigan
    Greater Manchester
    EnglandBritish110773520001
    BARNETT, Michael David
    26 Brough Road
    South Cave
    HU15 2BX Brough
    North Humberside
    Director
    26 Brough Road
    South Cave
    HU15 2BX Brough
    North Humberside
    United KingdomBritish102557780001
    BEEVER, Robert Neville
    Dalveen Woodhead Road
    Holmfirth
    HD7 1PX Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Dalveen Woodhead Road
    Holmfirth
    HD7 1PX Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish1646430001
    BIRD, Stephen Clive
    South End Cottage Orleans Road
    TW1 3BL Twickenham
    Middlesex
    Director
    South End Cottage Orleans Road
    TW1 3BL Twickenham
    Middlesex
    British47512480003
    BROSSET, Michel, Dr
    Am Sportplatz 6
    Monheim/Rhein
    D-40789
    Germany
    Director
    Am Sportplatz 6
    Monheim/Rhein
    D-40789
    Germany
    French75143240001
    DOE, Brian
    Whiterails Kington Langley
    SN15 5NS Chippenham
    Wiltshire
    Director
    Whiterails Kington Langley
    SN15 5NS Chippenham
    Wiltshire
    British30733690001
    FORSYTH, Calum James
    Galloping Lane
    Paddlebrook Barns Ditchford On Fosse
    GL56 9QT Moreton In Marsh
    The Stables
    Gloucestershire
    Director
    Galloping Lane
    Paddlebrook Barns Ditchford On Fosse
    GL56 9QT Moreton In Marsh
    The Stables
    Gloucestershire
    EnglandUk172355700002
    GALE, Paul Nicolas
    Ash Cottage
    Upper Wilshaw
    HD7 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    Director
    Ash Cottage
    Upper Wilshaw
    HD7 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    British72881120001
    GORANSSON, Rolf Claes Erik
    Unter Den Ulmen 1
    50968 Koln
    Germany
    Director
    Unter Den Ulmen 1
    50968 Koln
    Germany
    Sweden73403360003
    HASKELL, Peter
    1 Clarel Street
    Penistone
    S30 6AU Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    1 Clarel Street
    Penistone
    S30 6AU Sheffield
    South Yorkshire
    British1646450001
    HOUBEN, Philippus Petrus Franciscus Clemens
    Zuider Stationsweg 2d
    2061 He Bloemendaal
    The Netherlands
    Director
    Zuider Stationsweg 2d
    2061 He Bloemendaal
    The Netherlands
    NetherlandsDutch71084460001
    LEMON, David Edward Leonard
    6 Hillcrest Avenue
    South Normanton
    DE55 3NR Alfreton
    Derbyshire
    Director
    6 Hillcrest Avenue
    South Normanton
    DE55 3NR Alfreton
    Derbyshire
    British2649630001
    PHILLIPS, Robert Glyn
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    British842980001
    REDDICK, Terence William
    Shires Rest
    Gainsborough Road
    DN10 5DF Drakeholes
    Director
    Shires Rest
    Gainsborough Road
    DN10 5DF Drakeholes
    British92835860001
    SPRATT, Quentin Rodney
    Orchard Farm
    Brow Lane Antrobus
    CW9 6JY Northwich
    Cheshire
    Director
    Orchard Farm
    Brow Lane Antrobus
    CW9 6JY Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish60606400001
    TAYLOR, Andrew Rankine
    Highfield Hall
    306 Barnsley Road
    WF2 6AX Sandal
    Director
    Highfield Hall
    306 Barnsley Road
    WF2 6AX Sandal
    EnglandBritish158807800001
    THOMPSON, Kenneth
    105 Castle Rock Drive
    LE67 4SE Coalville
    Leicestershire
    Director
    105 Castle Rock Drive
    LE67 4SE Coalville
    Leicestershire
    British1680650001

    ¿Tiene HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 13 sept 2005
    Entregado el 23 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the afforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge,any real property,the charged deposits and all investments,shares and related rights.assignment,the insurances and the assigned deposits.floating charge,undertaking and assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V.(As Security Agent)
    Transacciones
    • 23 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 24 oct 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 23 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 abr 2002
    Entregado el 30 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to each beneficiary and all other money and obligations due or to become due by each other company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Including (I) vaillant house,medway city estate,trident close,rochester; K602936; (ii) land on the east side of dunster road,chelmsley wood,birmingham,west midlands; WM24946; (iii) unit D1,lowfields business park,elland,west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft,London (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 30 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pik debenture
    Creado el 18 abr 2002
    Entregado el 30 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to each beneficiary and all other money and obligations due or to become due by each other company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Including (I) vaillant house,medway city estate,trident close,rochester; K602936; (ii) land on the east side of dunster road,chelmsley wood,birmingham,west midlands; WM24946; (iii) unit D1,lowfields business park,elland,west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Aktiengesellschaft,London (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 30 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 dic 1980
    Entregado el 13 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10,901.18 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the chargeing subsitionery.
    Personas con derecho
    • Sachroder Ececutor & Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 13 ene 1989Registro de una carga

    ¿Tiene HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 oct 2013Fecha de disolución
    18 oct 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0