GENTRA LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGENTRA LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00544337
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GENTRA LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra GENTRA LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GENTRA LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ROYAL TRUST BANK03 nov 198603 nov 1986
    ROYAL TRUST COMPANY OF CANADA (THE)08 feb 195508 feb 1955

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GENTRA LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GENTRA LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 24 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 feb 2019 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director P Keith Hyde el 05 dic 2018

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ricky Tang el 05 dic 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017

    10 páginasAA

    Modification des détails de Gentra Holdings Company en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 ago 2018

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD England a Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street London EC2Y 9AW el 03 ago 2018

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 24 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    12 páginasAA

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 24 feb 2016

    22 páginasRP04

    Déclaration annuelle établie au 24 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 abr 2016

    Estado de capital el 13 abr 2016

    • Capital: GBP 123,714,259
    SH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 abr 2016Clarification A second filed AR01 was registered on 27/04/2016

    Cambio de datos del secretario Allen Yi el 11 mar 2014

    1 páginasCH03

    Nombramiento de Ricky Tang como director el 08 feb 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Bryan Kenneth Davis como director el 08 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    11 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 18 jul 2014

    • Capital: GBP 123,714,259
    3 páginasSH01

    Domicilio social registrado cambiado de , C/O Berwin Leighton Paisner Llp, D Hughes Adelaide House, London Bridge, London, EC4R 9HA a C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD el 25 sept 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 24 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 mar 2015

    Estado de capital el 20 mar 2015

    • Capital: GBP 108,866,959
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de GENTRA LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    YI, Allen
    Bay Street, Suite 330
    Toronto
    181
    Ontario M5j 2t3
    Canada
    Secretario
    Bay Street, Suite 330
    Toronto
    181
    Ontario M5j 2t3
    Canada
    British187547370001
    HYDE, P Keith
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Director
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    CanadaCanadian105505500001
    TANG, Ricky
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Director
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    United StatesCanadian206973950002
    GREGORY, Philip Charles
    Mulberry House
    26 North Grove Highgate
    N6 4SL London
    Secretario
    Mulberry House
    26 North Grove Highgate
    N6 4SL London
    British33287640001
    HYDE, P Keith
    26 Hambly Avenue
    Toronto
    Ontario M4e 2r6
    Canada
    Secretario
    26 Hambly Avenue
    Toronto
    Ontario M4e 2r6
    Canada
    Canadian105505500001
    IRONSIDE, Simon Anthony
    2 Orchard Mews
    Southgate Grove Islington
    N1 5BS London
    Secretario
    2 Orchard Mews
    Southgate Grove Islington
    N1 5BS London
    British31215710001
    MOODY, Patricia Joan
    8 Riverdene
    HA8 9TD Edgware
    Middlesex
    Secretario
    8 Riverdene
    HA8 9TD Edgware
    Middlesex
    British5286990001
    MULROY, Kieran Finbarr
    31 White Lodge Crescent
    L4C 9A1 Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Secretario
    31 White Lodge Crescent
    L4C 9A1 Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Canadian48720010001
    WICKS, Martin Theodore
    206 Britannia Drive 431
    Grand Cayman Box 30616 Smb
    Cayman Islands
    Secretario
    206 Britannia Drive 431
    Grand Cayman Box 30616 Smb
    Cayman Islands
    British62800470003
    BARR, Brian Ernest
    C/O Falconbridge Limited
    181 Bay Street Suite 200 Bce Place
    Toronto
    Ontario M5j2t3
    Canada
    Director
    C/O Falconbridge Limited
    181 Bay Street Suite 200 Bce Place
    Toronto
    Ontario M5j2t3
    Canada
    British Canadian7708890001
    BRIERLEY, Michael Charles
    45 Carisbrooke Gardens
    LE2 3PR Leicester
    Leicestershire
    Director
    45 Carisbrooke Gardens
    LE2 3PR Leicester
    Leicestershire
    British5287010001
    CAPE, Edmund Andrew
    75 Rosedale Heights Drive
    Toronto Ontario
    FOREIGN Canada
    Director
    75 Rosedale Heights Drive
    Toronto Ontario
    FOREIGN Canada
    Canadian36523210001
    CORNELISSEN, Michael Adriaan
    2061 Lakeshore Road East
    FOREIGN Oakville
    Ontario L6j 1x4
    Canada
    Director
    2061 Lakeshore Road East
    FOREIGN Oakville
    Ontario L6j 1x4
    Canada
    Canadian7708900001
    DAVENPORT, Maurice Hopwood
    Pines
    Dormans Park
    RH19 2LX East Grinstead
    West Sussex
    Director
    Pines
    Dormans Park
    RH19 2LX East Grinstead
    West Sussex
    United KingdomBritish6765160001
    DAVIS, Bryan Kenneth
    75 Buckingham Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 1r3
    Canada
    Director
    75 Buckingham Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 1r3
    Canada
    CanadaCanadian111671370001
    DONNE, David Lucas
    8 Montague Mews North
    W1H 1AH London
    Director
    8 Montague Mews North
    W1H 1AH London
    United KingdomBritish36527200001
    FAIRCHILD, Robert William
    26 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Director
    26 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    BritainBritish16613760002
    FELL, Fraser Matthews
    34 Glenorchy Road
    M3C 2P9 Don Mills
    Ontario
    Canada
    Director
    34 Glenorchy Road
    M3C 2P9 Don Mills
    Ontario
    Canada
    Canadian36469670001
    FREUND, Michael Walter
    272 Belsize Drive
    M4S 1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Director
    272 Belsize Drive
    M4S 1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian36469710001
    GAMBLE, Horace Roy
    River Lodge 1 Ravensbury Drive
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    Director
    River Lodge 1 Ravensbury Drive
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    British4379420001
    HARKER, William Clinton
    88 Hermitage Court
    Knighten Street
    E1 9PW London
    Director
    88 Hermitage Court
    Knighten Street
    E1 9PW London
    Canadian22380340003
    HOLBECHE, Philip Leslie
    7 Milburn Walk
    KT18 5JN Epsom
    Surrey
    Director
    7 Milburn Walk
    KT18 5JN Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish7708940001
    JOLY, Laurent Maurice
    4 Berkeley Gardens
    Kensington
    W8 4AP London
    Director
    4 Berkeley Gardens
    Kensington
    W8 4AP London
    Canadian48827400001
    KELLER-HOBSON, Donald Stephen Douglas
    48-50 Cannon Street
    EC4N 6LD London
    Director
    48-50 Cannon Street
    EC4N 6LD London
    Canadian36228770001
    KIMBALL, Marcus Richard, Lord
    Great Easton Manor
    LE16 8TB Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    Great Easton Manor
    LE16 8TB Market Harborough
    Leicestershire
    British7708960001
    LAMBERT, Allen Thomas
    483 Russell Hill Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5p 2s8
    Canada
    Director
    483 Russell Hill Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5p 2s8
    Canada
    Canadian7708970001
    LAURIE, Craig J
    The World Financial Center
    200 Vesey Street 11th Floor
    New York
    Ny 10281-1021
    Usa
    Director
    The World Financial Center
    200 Vesey Street 11th Floor
    New York
    Ny 10281-1021
    Usa
    Canadian105152590003
    LOVEGROVE, Philip Albert
    50 Thorley Lane
    Bishops Stortford
    CM23 4AD Hertfordshire
    Director
    50 Thorley Lane
    Bishops Stortford
    CM23 4AD Hertfordshire
    British35568310001
    MACDOUGALL, Hartland Molson
    Belfountain
    FOREIGN Ontario L0n 1bo
    Canada
    Director
    Belfountain
    FOREIGN Ontario L0n 1bo
    Canada
    Canadian7708980001
    MILLER, James William
    670 Fairmile Road
    V75 IR2 West Vancouver
    Bc
    Canada
    Director
    670 Fairmile Road
    V75 IR2 West Vancouver
    Bc
    Canada
    Canadian34028940001
    PORTER, Michael Andrew
    Pitt Cottage
    Church Street Great Baddow
    CM2 7AA Chelmsford
    Essex
    Director
    Pitt Cottage
    Church Street Great Baddow
    CM2 7AA Chelmsford
    Essex
    British32404350001
    STROYAN, Colin Strathearn Ropner
    Bridgend Of Teith
    FK16 6AD Doune
    Perthshire
    Director
    Bridgend Of Teith
    FK16 6AD Doune
    Perthshire
    United KingdomBritish1866210001
    WALKER, James Barrett
    53 Hillhurst Boulevard
    M5N 1N5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Director
    53 Hillhurst Boulevard
    M5N 1N5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian36469780001
    ONTARIO LIMITED
    Suite 1400
    70 York Street
    Toronto
    Ontario M5j 1sj
    Canada
    Director corporativo
    Suite 1400
    70 York Street
    Toronto
    Ontario M5j 1sj
    Canada
    48719890001
    SURREY INVESTMENTS INCORPORATED
    Box 30616 Smb
    Genesis Building Genesis Close
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Director corporativo
    Box 30616 Smb
    Genesis Building Genesis Close
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    68083360002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GENTRA LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Gentra Holdings Company
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    19 abr 2016
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Unlimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegistrar Of Companies (England And Wales
    Número de registro02022747
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene GENTRA LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment
    Creado el 11 nov 1994
    Entregado el 21 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the contract. The sum of £24,000 deposited with barclays finance company (isle of man) limited in the name of gentra limited.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 21 jul 1994
    Entregado el 29 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The obligations of the company to the chargee (as defined in the deed)
    Breve descripción
    The sum of £952,500 in account no 31538268.
    Personas con derecho
    • Guardian Assurance PLC
    Transacciones
    • 29 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over cash
    Creado el 13 abr 1994
    Entregado el 14 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the hutton guarantee and/or this charge
    Breve descripción
    Any sum or sums deposited in account no. 548-785-5 and any debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Canada (Iom) Limited
    Transacciones
    • 14 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 09 mar 1994
    Entregado el 24 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the counter-indemnity of even date and/or this agreement
    Breve descripción
    All of the company's right title benefit and interest in and to the obligations of the mortgagee to make payment of all amounts standing to the credit to the company's deutschmark call deposit account maintained with the mortgagee and designated "royal bank of canada europe limited re: gentra - cash collateral a/c" and in and to all interest arising in connection therewith and all other amounts credited to the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Canada Europe Limited
    Transacciones
    • 24 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage sale agreement
    Creado el 29 jul 1993
    Entregado el 05 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement (as defined)
    Breve descripción
    The sum of £7,918,194.00 credited to the midland bank PLC of poultry & princes street,london EC2P 2BX, account number 21381679 together with all sums in the future credited to that account and including interest accrued or accruing in the future on the account.
    Personas con derecho
    • Birmingham Midshires Mortgage Asset No.1 Limited
    Transacciones
    • 05 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security document
    Creado el 18 jun 1993
    Entregado el 05 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage the charged assets and by way of floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transacciones
    • 05 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental security document
    Creado el 04 jun 1993
    Entregado el 22 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the sub-participation agreement (as defined therein)
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all the additional charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transacciones
    • 22 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security document
    Creado el 17 may 1993
    Entregado el 07 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-participation agreement dated 17 may 1993.
    Breve descripción
    The chargor charges as beneficial owner in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets as defined.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Trust Bank (Caribbean) Corporation
    Transacciones
    • 07 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security document
    Creado el 07 may 1993
    Entregado el 26 may 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the sub-participation agreement dated 7 may 1993.
    Breve descripción
    The chargor as beneficial owner charges in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Trustco Limited.
    Transacciones
    • 26 may 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security document
    Creado el 23 abr 1993
    Entregado el 10 may 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Trustco Limited
    Transacciones
    • 10 may 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security document
    Creado el 22 abr 1993
    Entregado el 29 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement (as defined)
    Breve descripción
    All rights under any additional documents and charged assets...................see form 395.
    Personas con derecho
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transacciones
    • 29 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of amendment
    Creado el 14 abr 1993
    Entregado el 29 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For amending the sub-participation agreement dated 7.4.93 (as defined)
    Breve descripción
    All present and future rights......see form 395.
    Personas con derecho
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transacciones
    • 29 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security document
    Creado el 07 abr 1993
    Entregado el 22 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the "charged assets" being the loan portfolio and all rights of the company under any additional documents connected with the loan portfolio. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transacciones
    • 22 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security document
    Creado el 12 mar 1993
    Entregado el 26 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the "charged assets". See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Trust Bank (Caribbean) Corporation
    Transacciones
    • 26 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 27 mar 1986
    Entregado el 04 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land at eccleshall road, south, sheffield district of s yorks known as blenham nursing home t/n yew 41499. f/h land adjoining the above known as the blenheim lifestyle developments, t/nos. Stk 154003, ywe 41499. f/h land at old whittington chesterfield, derbyshire. F/h land off melbourne ave sheffield district of s yorks, (see doc M151 for full details).
    Personas con derecho
    • Royal Trust Bank (Jersey) Limited
    Transacciones
    • 04 abr 1986Registro de una carga
    • 31 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0