GEBERIT SERVICE
Visión general
Nombre de la empresa | GEBERIT SERVICE |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
Número de empresa | 00546129 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GEBERIT SERVICE?
- Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y equipo sanitario (46730) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra GEBERIT SERVICE?
Dirección de la sede social | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GEBERIT SERVICE?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
TWYFORD BATHROOMS | 07 feb 2001 | 07 feb 2001 |
CARADON BATHROOMS | 01 ene 1991 | 01 ene 1991 |
STELRAD BATHROOM PRODUCTS LIMITED | 22 dic 1987 | 22 dic 1987 |
ALLIA (UK) LIMITED | 30 jun 1983 | 30 jun 1983 |
ALLIA DOULTON BATHROOMS LIMITED | 01 abr 1981 | 01 abr 1981 |
DOULTON SANITARYWARE (BATHS) LIMITED | 18 mar 1955 | 18 mar 1955 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GEBERIT SERVICE?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GEBERIT SERVICE?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jun 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 05 jul 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jun 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GEBERIT SERVICE?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 40 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Steinmeier como director el 06 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gerd Karl Hailfinger como director el 06 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 42 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 42 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 17 páginas | MA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 34 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark David Larden como director el 24 mar 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Egon Renfordt-Sasse como director el 24 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Hopps como director el 12 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Derek Gallimore como director el 12 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Geberit Sales Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 jun 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Derek Gallimore en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 jun 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 29 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GEBERIT SERVICE?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRIS, Christine | Secretario | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | 203065830002 | |||||||||||
HOPPS, Simon | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | England | British | Director | 262317500001 | ||||||||
LARDEN, Mark David | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | England | British | Director | 227299690001 | ||||||||
STEINMEIER, Daniel | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | Germany | German | Director | 320207900001 | ||||||||
BROWN, Alan Derek | Secretario | 2 Hassam Parade Wolstanton ST5 9DS Newcastle Staffordshire | British | Director | 74066170001 | |||||||||
CAMERON, Ewen | Secretario | Oakfield House Station Road RG10 8EU Wargrave Berkshire | British | 2421530001 | ||||||||||
RICHARDSON, Karen | Secretario | Five Farthings Mansel Road SW19 4AA London | British | 38091040002 | ||||||||||
BBM SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Bethesda Street ST1 3DX Hanley Alexander House Stoke On Trent United Kingdom |
| 124385980001 | ||||||||||
EVER 1058 LIMITED | Secretario corporativo | Fourth Floor Cloth Hall Court, Infirmary Street LS1 2JB Leeds West Yorkshire | 69209680001 | |||||||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
BIGGIN, Anthony John | Director | Paddock End Ridley Hill Farm Ridley CW6 9RX Tarporley Cheshire | British | Manufacturing Director | 58388890001 | |||||||||
BLACKBURN, John Kenneth | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke-On-Trent Staffordshire United Kingdom | England | British | None | 113390120001 | ||||||||
BROWN, Alan Derek | Director | 2 Hassam Parade Wolstanton ST5 9DS Newcastle Staffordshire | England | British | Finance Director | 74066170001 | ||||||||
CARRIER, John | Director | Sandbeck Ridge 48 Willowmead Drive Prestbury SK10 4DD Macclesfield Cheshire | British | Director | 46823900001 | |||||||||
CHAMBRE, Peter Alan | Director | 25 Mount Ararat Road TW10 6PQ Richmond Surrey | British | Company Director | 17430990001 | |||||||||
COHEN, Daniel Charles | Director | 25 Berwyn Road TW10 5BP Richmond Surrey | British | Company Director | 2421540001 | |||||||||
CONLON, Michael Gerard | Director | 78 Demontfort Way ST14 8XY Uttoxeter Staffordshire | United Kingdom | Irish | Director | 96832770001 | ||||||||
CROY, Gordon Herbert Lawrence | Director | October House Hale End GU22 0LH Woking Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 113382680001 | ||||||||
FREUND, Juergen | Director | 36 Onslow Road Burwood Park KT12 5BA Walton On Thames Surrey | German | Company Director | 39320550001 | |||||||||
GALLIMORE, Derek | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | England | British | Head Of Technical Product Development | 153410450001 | ||||||||
HAILFINGER, Gerd Karl | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | Germany | German | Head Of Logistics | 202984500001 | ||||||||
HASTINGS, Charles Richard | Director | Hollybush House Pamington GL20 8LX Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 65787770002 | ||||||||
HUDSON, Brent William | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | England | British | Sales And Marketing Director Uk & Ireland | 191682470001 | ||||||||
KENWAY, Stephanie | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | England | British | Head Of Finance And Hr | 189382080001 | ||||||||
KITCHING, Christopher Reynard Edward | Director | 1 Rotherfield Road RG9 1NR Henley On Thames Oxfordshire | British | Company Director | 29101450002 | |||||||||
LARDEN, Mark David | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent | England | British | Managing Director | 134692030002 | ||||||||
LLEWELLYN, Trefor Wilmot | Director | Hill Farm House Ipsden OX10 6AD Wallingford Oxfordshire | England | British | Chartered Accountant | 107250730001 | ||||||||
MAHER, Diana | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire | Finland | Finnish | Director | 148987110001 | ||||||||
MCLEAN, Gavin Charles | Director | Beech Tree Farm Cloudside CW12 3QQ Congleton Cheshire | British | International Business Manager | 42935200001 | |||||||||
MILLS, Robert John Henry | Director | Hacheston Lodge The Street Hacheston IP13 0DL Woodbridge Suffolk | England | British | Company Director | 62567910001 | ||||||||
MONKS, Terence John | Director | Brantingham 24 Green Lane SL1 8DX Burnham Buckinghamshire | British | Company Director | 80344460001 | |||||||||
MOSS, Andrew John | Director | Field View Ham Lane Aston OX18 2DE Bampton Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 55351010001 | |||||||||
NILSSON, Gun | Director | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire United Kingdom | Sweden | Swedish | Director | 158150790001 | ||||||||
PEEDLE, Raymond John Bagnall | Director | The Beeches 401 Newcastle Road CW2 5EB Shavington Crewe Cheshire | British | Company Director | 41192410001 | |||||||||
PICKERING, Mark Ian | Director | 54 Broadway Road WR11 1BQ Evesham Worcestershire | England | British | Company Director | 107375670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GEBERIT SERVICE?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geberit Sales Limited | 24 jun 2019 | Edgehill Drive CV34 6NH Warwick Geberit House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Derek Gallimore | 01 sept 2017 | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke-On-Trent Geberit Service England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0