WB INDUSTRIAL LTD.
Visión general
| Nombre de la empresa | WB INDUSTRIAL LTD. |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00554067 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WB INDUSTRIAL LTD.?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra WB INDUSTRIAL LTD.?
| Dirección de la sede social | 32-38 Scrutton Street EC2A 4RQ London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WB INDUSTRIAL LTD.?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DARCHEM LIMITED | 01 sept 1955 | 01 sept 1955 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WB INDUSTRIAL LTD.?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 ene 2017 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 oct 2017 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 ene 2016 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WB INDUSTRIAL LTD.?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 oct 2017 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 02 nov 2017 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 oct 2016 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WB INDUSTRIAL LTD.?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Shaun Simon Wills como director el 16 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Amanda Claire Fogg como secretario el 16 feb 2021 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 oct 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 ene 2016 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 46 Colebrooke Row London N1 8AF a 32-38 Scrutton Street London EC2A 4RQ el 17 may 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Tim Morgan Davies como director el 08 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2015 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 005540670003, creada el 24 abr 2015 | 40 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Teresa Tideman como director el 23 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Tim Davies como director el 23 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Shaun Simon Wills como director el 23 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joanne Clare Bennett como director el 23 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 25 ene 2014 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Joanne Clare Bennett como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Johnson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 26 ene 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Amanda Claire Fogg como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WB INDUSTRIAL LTD.?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSOP, Patricia Mary | Secretario | 32 Nicosia Road SW18 3RN London | British | 501920002 | ||||||
| BRYAN, Paul Anthony Edward Peter | Secretario | 37 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | British | 25267050001 | ||||||
| CASH, Daphne Valerie | Secretario | 9 Marquis Close AL5 5QZ Harpenden Hertfordshire | British | 59646330005 | ||||||
| FOGG, Amanda Claire | Secretario | Scrutton Street EC2A 4RQ London 32-38 England | 181387660001 | |||||||
| HEARD, Nicholas James | Secretario | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | 132971860002 | ||||||
| JOHNSON, Ian Paul | Secretario | Tugwood Kings Lane SL6 9TZ Cookham Dean Berkshire | British | 76187110001 | ||||||
| SYKES, Richard John Davies | Secretario | 8 Oughton Close TS15 9SZ Yarm Cleveland | British | 9573440001 | ||||||
| WARBURTON, Jenny | Secretario | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | 156858460001 | |||||||
| WATT, Philip Graham | Secretario | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | 164017350001 | |||||||
| ALLEN, Paul Christopher | Director | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | United Kingdom | Irish | 185112730001 | |||||
| ALSOP, Patricia Mary | Director | 32 Nicosia Road SW18 3RN London | British | 501920002 | ||||||
| BENNETT, Joanne Clare | Director | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | England | British | 184759270001 | |||||
| BRYAN, Paul Anthony Edward Peter | Director | 37 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | British | 25267050001 | ||||||
| CASH, Daphne Valerie | Director | 9 Marquis Close AL5 5QZ Harpenden Hertfordshire | British | 59646330005 | ||||||
| CHADWICK, Allan | Director | 32 Chamberlain Way HA5 2AX Pinner Middlesex | England | British | 580310001 | |||||
| DAVIES, Tim Morgan | Director | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | United Kingdom | British | 197113400001 | |||||
| FABIAN, Andrew Mark | Director | 139 Woodwarde Road SE22 8UP London | United Kingdom | British | 61022990001 | |||||
| FINCH, Russell | Director | 9 Park Place W5 5NQ London | British | 70159860001 | ||||||
| HANN, James, Sir | Director | Bramley Cottage Bullhouse Lane Wrington BS40 5NY Bristol North Somerset | British | 49051030001 | ||||||
| HYNES, Brendan | Director | Elm Lodge Stoneyhurst Crescent Culcheth WA3 4DS Warrington Cheshire | England | English | 112309920001 | |||||
| JOHNSON, Ian Paul | Director | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | United Kingdom | British | 76187110001 | |||||
| KEMPSTER, Jonathan | Director | 144 Finchampstead Road RG41 2NU Wokingham Berkshire | British | 73764250001 | ||||||
| MENZIES, John Webster | Director | 12 Church Street Dunnington YO19 5PW York North Yorkshire | British | 73637350001 | ||||||
| MEREDITH, Malcolm Leslie | Director | 8 Hylton Road TS26 0AG Hartlepool Cleveland | British | 9573500001 | ||||||
| MILLS-BAKER, Andrew James | Director | 8 The Warren AL5 2NH Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 802870002 | |||||
| MORRIS, Sarah | Director | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | England | British | 174804590001 | |||||
| PARR, Thomas Donald | Director | Homestead Homestead Road Disley SK12 2JP Stockport Cheshire | British | 501930002 | ||||||
| PARSONS, John Victor | Director | Whashton Lodge Whashton DL11 7JL Richmond North Yorkshire | British | 34910720001 | ||||||
| REID, William | Director | Baykers Lamb Lane Sible Hedingham CO9 3RS Halstead Essex | British | 23538370001 | ||||||
| ROBERTS, Stephen John | Director | 11 Warden Court Cuckfield RH17 5DN Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 67757790002 | |||||
| TIDEMAN, Teresa Mary | Director | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | England | British | 150161210001 | |||||
| VAUGHAN, Bernard James | Director | 6 Kelsterne Close TS15 9SX Yarm Cleveland | British | 14332130001 | ||||||
| WILLS, Shaun Simon | Director | Scrutton Street EC2A 4RQ London 32-38 England | England | British | 185717270001 | |||||
| WRIGHT, James Leslie | Director | 3 Village Farm Middleton Tyas DL10 6SQ Richmond North Yorkshire | British | 14149590001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WB INDUSTRIAL LTD.?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Baird Limited | 06 abr 2016 | Rutland Court EH3 8EY Edinburgh 1 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene WB INDUSTRIAL LTD. alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 24 abr 2015 Entregado el 27 abr 2015 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 09 dic 2009 Entregado el 18 dic 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating security document | Creado el 30 sept 2002 Entregado el 04 oct 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0