MALTON MOTORS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MALTON MOTORS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00554231 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MALTON MOTORS LIMITED?
- Venta de coches nuevos y vehículos de motor ligeros (45111) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
- Mantenimiento y reparación de vehículos de motor (45200) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
- Comercio al por mayor de piezas y accesorios de vehículos de motor (45310) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra MALTON MOTORS LIMITED?
| Dirección de la sede social | First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MALTON MOTORS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MALTON MOTORS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 1 | 2 páginas | MR04 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Thomas Andrew Dale como director el 29 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Elizabeth Louise Hancox como director el 20 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Thomas Andrew Dale como director el 04 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anton Clive Jeary como director el 04 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Dr Elizabeth Louise Hancox como director el 01 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Claire Louise Catlin como director el 21 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Claire Louise Catlin el 01 sept 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de European Motor Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2018 | 5 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del secretario Inchcape Uk Corporate Management Limited el 01 abr 2018 | 3 páginas | CH04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT a First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN el 06 abr 2018 | 2 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Claire Louise Catlin como director el 23 sept 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de MALTON MOTORS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | Secretario corporativo | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham United Kingdom |
| 100307260072 | ||||||||||
| WHEATLEY, Martin Peter | Director | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | 55180460002 | |||||||||
| BEACHAM, Mark Derrick | Secretario | Austwick Lane Emerson Valley MK4 2DR Milton Keynes 11 Buckinghamshire United Kingdom | British | 135313320001 | ||||||||||
| CATLIN, Claire Louise | Director | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | 270101940001 | |||||||||
| CAYGILL, Christopher Charles | Director | 8 Westpark Drive Westlands Faverdale DL3 0TB Darlington County Durham | British | 56689810001 | ||||||||||
| DALE, Thomas Andrew | Director | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | United Kingdom | British | 260286850001 | |||||||||
| HANCOX, Elizabeth Louise, Dr | Director | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | United Kingdom | British | 210216760001 | |||||||||
| JEARY, Anton Clive | Director | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | 169892630001 | |||||||||
| KAYE, Keith Melvin | Director | Gold House 58 Easton Road YO16 4DB Bridlington East Yorkshire | England | British | 162406960001 | |||||||||
| LOCK, Spencer | Director | The Dower House Itchen Abbas SO21 1BQ Winchester Hampshire | England | British | 92493930001 | |||||||||
| MCCLUSKEY, Ross | Director | Langford Lane Kidlington OX5 1HT Oxford Inchcape House | United Kingdom | British | 165677350002 | |||||||||
| MCCORMACK, Connor | Director | New College House Alchester Road OX26 1UN Chesterton Oxfordshire | United Kingdom | British | 108832810002 | |||||||||
| PALMER, Richard Terence | Director | Littlethorpe Cleeve Road RG8 9BJ Goring | England | British | 16571890002 | |||||||||
| RONCHETTI, Marc Arthur | Director | New Road Croxley Green WD3 3EP Rickmansworth 22 Hertfordshire | England | British | 123180830001 | |||||||||
| WILSON, Ann Chrisette | Director | The Kingswood Ridgemount Road SL5 9RW Sunningdale Berkshire | England | British | 14811650002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MALTON MOTORS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Motor Holdings Limited | 06 abr 2016 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor, Unit 3140, Park Square United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MALTON MOTORS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 15 dic 2003 Entregado el 16 dic 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from european motor holdings PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All that f/h property being land lying to the north of preston lane preston farm industrial estate stockton-on-tees t/n CE101585. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 26 ene 1993 Entregado el 28 ene 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All the companys present and future stock of new and used motore vehicles and all the companys right title and interest therein and all moneys due and all goods given in exchange for the motor vehicles. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 nov 1991 Entregado el 18 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 28/10/91 | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 27 may 1988 Entregado el 02 jun 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 10 feb 1988 Entregado el 19 feb 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Breve descripción All those monies which may from time to time owing to malton motors limited by bmw (GB) limited in respect of refunds of monies paid by or by direction of malton motors limited to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis the debenture provides that malton motors limited shall not without the prior written consent of bmw finance (GB) limited create or permit to come into being any mortgage charge or assignment in respect of the monies assigned by the debenture. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0