CLYDE PUMPS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CLYDE PUMPS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00558720 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLYDE PUMPS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CLYDE PUMPS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Green Road Penistone S36 6BJ Sheffield |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLYDE PUMPS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DAVID BROWN RADICON LIMITED | 01 may 1990 | 01 may 1990 |
| DAVID BROWN GEAR INDUSTRIES LIMITED | 13 jul 1988 | 13 jul 1988 |
| DAVID BROWN INDUSTRIES LIMITED | 15 dic 1955 | 15 dic 1955 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLYDE PUMPS LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2016 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2017 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CLYDE PUMPS LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 27 may 2018 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 10 jun 2018 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 27 may 2017 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLYDE PUMPS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauración por orden judicial | 2 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Jeremy Wade Smeltser el 26 sept 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Paul Andrew Cahill como director el 26 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Balkar Sohal como director el 26 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Lucius Lilly como director el 03 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Stephen Tsoris como director el 03 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Balkar Sohal el 22 sept 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mark Edward Shanahan el 22 sept 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Brown como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jeremy Wade Smeltser el 01 ene 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Kevin Lucius Lilly el 01 ene 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CLYDE PUMPS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL, Paul Andrew | Director | Hambridge Road RG14 5TR Newbury Spx International Limited Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 202085370001 | |||||
| SHANAHAN, Mark Edward | Director | Ocean House, Towers Business Park Didsbury M20 2LY Manchester C/O Spx Europe Shared Services Limited United Kingdom | England | British | 165707440001 | |||||
| SMELTSER, Jeremy Wade | Director | Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte 13320 North Carolina Usa | United States | American | 163313000001 | |||||
| TSORIS, Stephen | Director | Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte 13320 North Carolina Usa | United States | American | 197069810001 | |||||
| AINSCOUGH, Paul Wayne | Secretario | 22 Carrbrook Drive Atherton M46 9HT Manchester Lancashire | British | 1876370001 | ||||||
| ASHMAN, Linda Margaret | Secretario | Blue Fields 421 Huddersfield Road, Shelley HD8 8NE Woodhouse Huddersfield West Yorkshire | British | 86730910001 | ||||||
| BROWN, Thomas James | Secretario | 57 Randolph Road G11 7JJ Glasgow | British | 60773560001 | ||||||
| TULLEY, Karen Ann | Secretario | Knottside Farm The Knott, Pateley Bridge HG3 5DQ Harrogate North Yorkshire | British | 59112980002 | ||||||
| ADAMS, Simon John | Director | Bridgefoot Cottage Bridgefoot Silkstone S75 4LZ Barnsley South Yorkshire | British | 68065980001 | ||||||
| AINSCOUGH, Paul Wayne | Director | Apartment 301 Valley Mill Cottonfields Eagley Brook BL7 9DY Bolton Lancashire | England | British | 1876370002 | |||||
| BAILEY, Roger | Director | 51 Upper Hall View Northowram HX3 7ET Halifax West Yorkshire | United Kingdom | British | 29110660002 | |||||
| BOYD, Norman | Director | 15 Marina Towers Boscombe BH5 1BJ Bournemouth Dorset | British | 55402440001 | ||||||
| BROWN, Christopher John | Director | The Grange Bent Lane Sutton In Craven BD20 7AL Keighley West Yorkshire | England | British | 1698880001 | |||||
| COOK, Christopher David | Director | Beauchamp House Church Road CV35 8AN Sherbourne Warwickshire | United Kingdom | British | 1698890001 | |||||
| DOWIE, Allan Cameron | Director | Arkaig Place Newton Mearns G77 5PH Glasgow 7 | United Kingdom | British | 132053460001 | |||||
| ELSBORG, Anton Cecil | Director | Woodstock Thorpe Lane LS20 8LE Leeds West Yorkshire | England | British | 93041580001 | |||||
| EVANS, Simon James Peter | Director | 2 Nursery Close Leyland PR5 1NS Preston Lancashire | British | 45872320001 | ||||||
| HOLLAND, Mark Harry | Director | 219 Huddersfield Road Thongsbridge HD9 3TT Holmfirth West Yorkshire | United Kingdom | British | 98168130001 | |||||
| LILLY, Kevin Lucius | Director | Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte 13320 North Carolina Usa | Usa | American | 165775730001 | |||||
| LINDA JEAN, Norman | Director | 76 Ennerdale Drive CW12 4FL Congleton Cheshire | British | 71657260001 | ||||||
| MAKIN, David | Director | 54 Lamb Hall Road Longwood HD7 7NW Huddersfield West Yorkshire | British | 45872440001 | ||||||
| MCBRIDE, Michael | Director | 51a Middleton Lane Middleton St George DL2 1AL Darlington County Durham | British | 45872470001 | ||||||
| MCCANN, Michael | Director | Alderley 157 Longedge Lane Wingerworth S42 6PR Chesterfield Derbyshire | British | 57468200001 | ||||||
| O'LEARY, Patrick Joseph | Director | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13515 Nc 28277 Usa | United States | American | 61807850002 | |||||
| PENNING, Graham Michael | Director | 36 Riley Park Kirkburton HD8 0SA Huddersfield West Yorkshire | England | British | 12354670001 | |||||
| PILKINGTON, Craig Edward | Director | 233 Huddersfield Road Thongsbridge HD7 2TT Huddersfield West Yorkshire | British | 48655240001 | ||||||
| PRIDEAUX, Christopher Clive | Director | 21a Primrose Lane Kirkburton HD8 0QY Huddersfield West Yorkshire | England | British | 64753680001 | |||||
| SCOTT, Greaeme | Director | 19 Rufford Road HD3 4RR Huddersfield West Yorkshire | British | 71161000001 | ||||||
| SOHAL, Balkar | Director | Hambridge Road RG14 5TR Newbury C/O Spx Flow Technology Limited Berkshire United Kingdom | England | English | 161546310001 | |||||
| WHITTLE, Andrew Paul | Director | 61 Doeford Close Culcheth WA3 4DL Warrington Cheshire | England | British | 108088160001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CLYDE PUMPS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clyde Union Db Limited | 06 abr 2016 | S36 6BJ Penistone Green Road Sheffield United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CLYDE PUMPS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Creado el 24 sept 1992 Entregado el 07 oct 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción See form 395 refg m*91. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee and debenture | Creado el 24 ene 1990 Entregado el 05 feb 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee (as agent) and to the lenders (as defined) under each of the financing documents to which such obligor is a party | |
Breve descripción (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee and debenture | Creado el 24 ene 1990 Entregado el 06 feb 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from each obligor (as defined) to bankers trust company(the senior) leaders agent) as agent and trustee for itself, canadian imperial bank of commerce and bankers trust international limited (the senior leaders) under each of the financing. Ducuments to which such obligor is a party | |
Breve descripción (Please see doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 27 jun 1989 Entregado el 04 jul 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Single debenture | Creado el 27 jun 1989 Entregado el 30 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 08 may 1989 Entregado el 15 may 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0