CLYDE PUMPS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCLYDE PUMPS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00558720
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CLYDE PUMPS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra CLYDE PUMPS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Green Road
    Penistone
    S36 6BJ Sheffield
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLYDE PUMPS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DAVID BROWN RADICON LIMITED01 may 199001 may 1990
    DAVID BROWN GEAR INDUSTRIES LIMITED13 jul 198813 jul 1988
    DAVID BROWN INDUSTRIES LIMITED15 dic 195515 dic 1955

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CLYDE PUMPS LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2016
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2017
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CLYDE PUMPS LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta27 may 2018
    Próxima declaración de confirmación vence10 jun 2018
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta27 may 2017
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLYDE PUMPS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Restauración por orden judicial

    2 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 27 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jun 2016

    Estado de capital el 02 jun 2016

    • Capital: GBP 4,434,029
    SH01

    Cambio de datos del director Jeremy Wade Smeltser el 26 sept 2015

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Paul Andrew Cahill como director el 26 sept 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Balkar Sohal como director el 26 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jun 2015

    Estado de capital el 29 jun 2015

    • Capital: GBP 4,434,029
    SH01

    Cese del nombramiento de Kevin Lucius Lilly como director el 03 abr 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Stephen Tsoris como director el 03 abr 2015

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Balkar Sohal el 22 sept 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mark Edward Shanahan el 22 sept 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 jun 2014

    Estado de capital el 11 jun 2014

    • Capital: GBP 4,434,029
    SH01

    legacy

    páginasANNOTATION

    legacy

    páginasANNOTATION

    Cese del nombramiento de Thomas Brown como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Jeremy Wade Smeltser el 01 ene 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Kevin Lucius Lilly el 01 ene 2013

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de CLYDE PUMPS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CAHILL, Paul Andrew
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish202085370001
    SHANAHAN, Mark Edward
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    Director
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    EnglandBritish165707440001
    SMELTSER, Jeremy Wade
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    Director
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmerican163313000001
    TSORIS, Stephen
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    Director
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmerican197069810001
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    22 Carrbrook Drive
    Atherton
    M46 9HT Manchester
    Lancashire
    Secretario
    22 Carrbrook Drive
    Atherton
    M46 9HT Manchester
    Lancashire
    British1876370001
    ASHMAN, Linda Margaret
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretario
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    British86730910001
    BROWN, Thomas James
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    Secretario
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    British60773560001
    TULLEY, Karen Ann
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    British59112980002
    ADAMS, Simon John
    Bridgefoot Cottage Bridgefoot
    Silkstone
    S75 4LZ Barnsley
    South Yorkshire
    Director
    Bridgefoot Cottage Bridgefoot
    Silkstone
    S75 4LZ Barnsley
    South Yorkshire
    British68065980001
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    Director
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish1876370002
    BAILEY, Roger
    51 Upper Hall View
    Northowram
    HX3 7ET Halifax
    West Yorkshire
    Director
    51 Upper Hall View
    Northowram
    HX3 7ET Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritish29110660002
    BOYD, Norman
    15 Marina Towers
    Boscombe
    BH5 1BJ Bournemouth
    Dorset
    Director
    15 Marina Towers
    Boscombe
    BH5 1BJ Bournemouth
    Dorset
    British55402440001
    BROWN, Christopher John
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    Director
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritish1698880001
    COOK, Christopher David
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    Director
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritish1698890001
    DOWIE, Allan Cameron
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    Director
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    United KingdomBritish132053460001
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish93041580001
    EVANS, Simon James Peter
    2 Nursery Close
    Leyland
    PR5 1NS Preston
    Lancashire
    Director
    2 Nursery Close
    Leyland
    PR5 1NS Preston
    Lancashire
    British45872320001
    HOLLAND, Mark Harry
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    Director
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritish98168130001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    Director
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    UsaAmerican165775730001
    LINDA JEAN, Norman
    76 Ennerdale Drive
    CW12 4FL Congleton
    Cheshire
    Director
    76 Ennerdale Drive
    CW12 4FL Congleton
    Cheshire
    British71657260001
    MAKIN, David
    54 Lamb Hall Road
    Longwood
    HD7 7NW Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    54 Lamb Hall Road
    Longwood
    HD7 7NW Huddersfield
    West Yorkshire
    British45872440001
    MCBRIDE, Michael
    51a Middleton Lane
    Middleton St George
    DL2 1AL Darlington
    County Durham
    Director
    51a Middleton Lane
    Middleton St George
    DL2 1AL Darlington
    County Durham
    British45872470001
    MCCANN, Michael
    Alderley 157 Longedge Lane
    Wingerworth
    S42 6PR Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Alderley 157 Longedge Lane
    Wingerworth
    S42 6PR Chesterfield
    Derbyshire
    British57468200001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    Director
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish12354670001
    PILKINGTON, Craig Edward
    233 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD7 2TT Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    233 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD7 2TT Huddersfield
    West Yorkshire
    British48655240001
    PRIDEAUX, Christopher Clive
    21a Primrose Lane
    Kirkburton
    HD8 0QY Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    21a Primrose Lane
    Kirkburton
    HD8 0QY Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish64753680001
    SCOTT, Greaeme
    19 Rufford Road
    HD3 4RR Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    19 Rufford Road
    HD3 4RR Huddersfield
    West Yorkshire
    British71161000001
    SOHAL, Balkar
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandEnglish161546310001
    WHITTLE, Andrew Paul
    61 Doeford Close
    Culcheth
    WA3 4DL Warrington
    Cheshire
    Director
    61 Doeford Close
    Culcheth
    WA3 4DL Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish108088160001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CLYDE PUMPS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    S36 6BJ Penistone
    Green Road
    Sheffield
    United Kingdom
    06 abr 2016
    S36 6BJ Penistone
    Green Road
    Sheffield
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00331925
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CLYDE PUMPS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture
    Creado el 24 sept 1992
    Entregado el 07 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 refg m*91. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 24 ene 1990
    Entregado el 05 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee (as agent) and to the lenders (as defined) under each of the financing documents to which such obligor is a party
    Breve descripción
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Trust Britarnia Mezzanine Capital B.V as Agent.
    Transacciones
    • 05 feb 1990Registro de una carga
    • 30 nov 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 24 ene 1990
    Entregado el 06 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from each obligor (as defined) to bankers trust company(the senior) leaders agent) as agent and trustee for itself, canadian imperial bank of commerce and bankers trust international limited (the senior leaders) under each of the financing. Ducuments to which such obligor is a party
    Breve descripción
    (Please see doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bankers Trust Company (As Agent)
    Transacciones
    • 06 feb 1990Registro de una carga
    • 30 nov 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 jun 1989
    Entregado el 04 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jul 1989Registro de una carga
    Single debenture
    Creado el 27 jun 1989
    Entregado el 30 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jun 1989Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 08 may 1989
    Entregado el 15 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 may 1989Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0